Búsqueda

  • 07-05-2022 Statement of Basis
    07-05-2022 Statement of Basis

    jul. 8, 2022 ... Bay Area Air Quality Management District 375 Beale St, Suite 600 San Francisco, CA 94105 (415) 749-5000 Proposed Statement of Basis for RENEWAL of MAJOR FACILITY REVIEW PERMIT ...

    Read More
    (388 Kb PDF, 31 pgs)

    jul. 8, 2022 ... Bay Area Air Quality Management District 375 Beale St, Suite 600 San Francisco, CA 94105 (415) 749-5000 Proposed Statement of Basis for RENEWAL of MAJOR FACILITY REVIEW PERMIT ...

  • Four Scheduled Hearings
    Four Scheduled Hearings

    ago. 25, 2011 ... HEARING BOARD CALENDAR BAY AREA AIR QUALITY MANAGEMENT DISTRICT STATE OF CALIFORNIA th 939 Ellis Street – 7 Floor Board Room San Francisco, California 94109 415-749-5073 THURSDAY, ...

    Read More
    (96 Kb PDF, 4 pgs)

    ago. 25, 2011 ... HEARING BOARD CALENDAR BAY AREA AIR QUALITY MANAGEMENT DISTRICT STATE OF CALIFORNIA th 939 Ellis Street – 7 Floor Board Room San Francisco, California 94109 415-749-5073 THURSDAY, ...

  • Semi-Annual Monitoring Report 2019 B
    Semi-Annual Monitoring Report 2019 B

    may. 26, 2020 ... REDWOOD LANDFILL, INC. P.O. Box 793 8950 Redwood Highway Novato, CA 94948 (415) 892-2851 (415) 898-1354 Fax May 28, 2020 Director of Compliance and Enforcement Director of the Air ...

    Read More
    (22 Mb PDF, 454 pgs)

    may. 26, 2020 ... REDWOOD LANDFILL, INC. P.O. Box 793 8950 Redwood Highway Novato, CA 94948 (415) 892-2851 (415) 898-1354 Fax May 28, 2020 Director of Compliance and Enforcement Director of the Air ...

  • 669468 Public Notice Vietnamese
    669468 Public Notice Vietnamese

    mar. 13, 2023 ... BỐ CÁO CÔNG CỘNG Ngày 21 tháng 3 năm 2023 KÍNH GỬI: Tất cả các cư gia và cơ sở thương mại nằm trong phạm vi 1.000 bộ (feet) cách nguồn gây ra ô nhiễm không khí mới hoặc được sửa đổi sau ...

    Read More
    (258 Kb PDF, 2 pgs)

    mar. 13, 2023 ... BỐ CÁO CÔNG CỘNG Ngày 21 tháng 3 năm 2023 KÍNH GỬI: Tất cả các cư gia và cơ sở thương mại nằm trong phạm vi 1.000 bộ (feet) cách nguồn gây ra ô nhiễm không khí mới hoặc được sửa đổi sau ...

  • 672028 Public Notice Vietnamese
    672028 Public Notice Vietnamese

    mar. 14, 2023 ... BỐ CÁO CÔNG CỘNG Ngày 21 tháng 3 năm 2023 KÍNH GỬI: Tất cả các cư gia và cơ sở thương mại nằm trong phạm vi 1.000 bộ (feet) cách nguồn gây ra ô nhiễm không khí mới hoặc được sửa đổi sau ...

    Read More
    (264 Kb PDF, 2 pgs)

    mar. 14, 2023 ... BỐ CÁO CÔNG CỘNG Ngày 21 tháng 3 năm 2023 KÍNH GỬI: Tất cả các cư gia và cơ sở thương mại nằm trong phạm vi 1.000 bộ (feet) cách nguồn gây ra ô nhiễm không khí mới hoặc được sửa đổi sau ...

  • 730955 Public Notice Vietnamese
    730955 Public Notice Vietnamese

    Mar 2, 2026 ... BỐ CÁO CÔNG CỘNG Ngày 11 tháng 3 năm 2026 KÍNH GỬI: Tất cả các cư gia và cơ sở thương mại nằm trong phạm vi 1.000 bộ (305 m) cách nguồn gây ra ô nhiễm không khí mới hoặc được sửa đổi sau ...

    Read More
    (348 Kb PDF, 2 pgs)

    Mar 2, 2026 ... BỐ CÁO CÔNG CỘNG Ngày 11 tháng 3 năm 2026 KÍNH GỬI: Tất cả các cư gia và cơ sở thương mại nằm trong phạm vi 1.000 bộ (305 m) cách nguồn gây ra ô nhiễm không khí mới hoặc được sửa đổi sau ...

  • 724878 Public Notice Vietnamese
    724878 Public Notice Vietnamese

    Jan 26, 2026 ... BỐ CÁO CÔNG CỘNG Ngày 9 tháng 2 năm 2026 KÍNH GỬI: Tất cả các cư gia và cơ sở thương mại nằm trong phạm vi 1.000 bộ (305 m) cách nguồn gây ra ô nhiễm không khí mới hoặc được sửa đổi sau ...

    Read More
    (304 Kb PDF, 2 pgs)

    Jan 26, 2026 ... BỐ CÁO CÔNG CỘNG Ngày 9 tháng 2 năm 2026 KÍNH GỬI: Tất cả các cư gia và cơ sở thương mại nằm trong phạm vi 1.000 bộ (305 m) cách nguồn gây ra ô nhiễm không khí mới hoặc được sửa đổi sau ...

  • Proposed Permit
    Proposed Permit

    nov. 6, 2012 ... Bay Area Air Quality Management District 939 Ellis Street San Francisco, CA 94109 (415) 771-6000 DraftProposed MAJOR FACILITY REVIEW PERMIT Issued To: Owens Corning Facility ...

    Read More
    (2 Mb PDF, 204 pgs)

    nov. 6, 2012 ... Bay Area Air Quality Management District 939 Ellis Street San Francisco, CA 94109 (415) 771-6000 DraftProposed MAJOR FACILITY REVIEW PERMIT Issued To: Owens Corning Facility ...

  • 721059 Public Notice Vietnamese
    721059 Public Notice Vietnamese

    Jan 13, 2026 ... BỐ CÁO CÔNG CỘNG Ngày 2 tháng 2 năm 2026 KÍNH GỬI: Tất cả các cư gia và cơ sở thương mại nằm trong phạm vi 1.000 bộ (305 m) cách nguồn gây ra ô nhiễm không khí mới hoặc được sửa đổi sau ...

    Read More
    (289 Kb PDF, 2 pgs)

    Jan 13, 2026 ... BỐ CÁO CÔNG CỘNG Ngày 2 tháng 2 năm 2026 KÍNH GỬI: Tất cả các cư gia và cơ sở thương mại nằm trong phạm vi 1.000 bộ (305 m) cách nguồn gây ra ô nhiễm không khí mới hoặc được sửa đổi sau ...

  • Semi-Annual Monitoring Report 2020 B
    Semi-Annual Monitoring Report 2020 B

    may. 26, 2021 ... REDWOOD LANDFILL, INC. P.O. Box 793 8950 Redwood Highway Novato, CA 94948 (415) 892-2851 (415) 898-1354 Fax May 27, 2021 Director of Compliance and Enforcement Director of the Air ...

    Read More
    (16 Mb PDF, 424 pgs)

    may. 26, 2021 ... REDWOOD LANDFILL, INC. P.O. Box 793 8950 Redwood Highway Novato, CA 94948 (415) 892-2851 (415) 898-1354 Fax May 27, 2021 Director of Compliance and Enforcement Director of the Air ...

  • Semi-Annual Monitoring Report 2020 A
    Semi-Annual Monitoring Report 2020 A

    nov. 18, 2020 ... Tri-Cities Recycling and Recovery Facility 7010 Auto Mall Parkway, Fremont, CA 94538 November 23, 2020 Director of Compliance and Enforcement Director of Enforcement Division Bay Area ...

    Read More
    (5 Mb PDF, 119 pgs)

    nov. 18, 2020 ... Tri-Cities Recycling and Recovery Facility 7010 Auto Mall Parkway, Fremont, CA 94538 November 23, 2020 Director of Compliance and Enforcement Director of Enforcement Division Bay Area ...

  • 31180 Public Notice Vietnamese
    31180 Public Notice Vietnamese

    Mar 7, 2026 ... BỐ CÁO CÔNG CỘNG Ngày 13 tháng 3 năm 2026 KÍNH GỬI: Tất cả các cư gia và cơ sở thương mại nằm trong phạm vi 1.000 bộ (305 m) cách nguồn gây ra ô nhiễm không khí mới hoặc được sửa đổi sau ...

    Read More
    (295 Kb PDF, 2 pgs)

    Mar 7, 2026 ... BỐ CÁO CÔNG CỘNG Ngày 13 tháng 3 năm 2026 KÍNH GỬI: Tất cả các cư gia và cơ sở thương mại nằm trong phạm vi 1.000 bộ (305 m) cách nguồn gây ra ô nhiễm không khí mới hoặc được sửa đổi sau ...

  • Semi-Annual Monitoring Report 2021 A
    Semi-Annual Monitoring Report 2021 A

    Oct 28, 2021 ... October 27, 2021 Director of Compliance and Enforcement Director of the Air Division Bay Area Air Quality Management District USEPA, Region IX 375 Beale Street, Suite 600 75 Hawthorne ...

    Read More
    (18 Mb PDF, 335 pgs)

    Oct 28, 2021 ... October 27, 2021 Director of Compliance and Enforcement Director of the Air Division Bay Area Air Quality Management District USEPA, Region IX 375 Beale Street, Suite 600 75 Hawthorne ...

  • Semi-Annual Monitoring Report 2020 B
    Semi-Annual Monitoring Report 2020 B

    Apr 28, 2021 ... April 28, 2021 Director of Compliance and Enforcement Director of the Air Division Bay Area Air Quality Management District USEPA, Region IX 375 Beale Street, Suite 600 75 Hawthorne ...

    Read More
    (19 Mb PDF, 293 pgs)

    Apr 28, 2021 ... April 28, 2021 Director of Compliance and Enforcement Director of the Air Division Bay Area Air Quality Management District USEPA, Region IX 375 Beale Street, Suite 600 75 Hawthorne ...

  • Board Agenda
    Board Agenda

    May 31, 2012 ... BOARD OF DIRECTORS REGULAR MEETING JUNE 6, 2012 A meeting of the Bay Area Air Quality Management District Board of Directors will be held at 9:45 th a.m. in the 7 Floor ...

    Read More
    (3 Mb PDF, 163 pgs)

    May 31, 2012 ... BOARD OF DIRECTORS REGULAR MEETING JUNE 6, 2012 A meeting of the Bay Area Air Quality Management District Board of Directors will be held at 9:45 th a.m. in the 7 Floor ...

  • Semi-Annual Monitoring Report 2024 B
    Semi-Annual Monitoring Report 2024 B

    Apr 27, 2024 ... Guadalupe Rubbish Disposal Company, Inc. 15999 Guadalupe Mines Road PO Box 20957 San Jose, California 95160 T: 408.268.1670 April 23, 2024 Director of Compliance and Enforcement ...

    Read More
    (22 Mb PDF, 382 pgs)

    Apr 27, 2024 ... Guadalupe Rubbish Disposal Company, Inc. 15999 Guadalupe Mines Road PO Box 20957 San Jose, California 95160 T: 408.268.1670 April 23, 2024 Director of Compliance and Enforcement ...

  • Presentation
    Presentation

    nov. 8, 2024 ... EV Coordinating Council November 7, 2024 Meeting Welcome! We will begin shortly. Feel free to change your display name to include your organization and pronouns. This meeting will be ...

    Read More
    (25 Mb PDF, 94 pgs)

    nov. 8, 2024 ... EV Coordinating Council November 7, 2024 Meeting Welcome! We will begin shortly. Feel free to change your display name to include your organization and pronouns. This meeting will be ...

  • Semi-Annual Monitoring Report 2023 B
    Semi-Annual Monitoring Report 2023 B

    ago. 6, 2024 ... Tesoro Refining & Marketing Company LLC Martinez Renewable Fuels Facility 150 Solano Way Martinez, CA 94553 August 6, 2024 VIA EMAIL TO COMPLIANCE@BAAQMD.GOV Mr. Jeffrey ...

    Read More
    (1016 Kb PDF, 11 pgs)

    ago. 6, 2024 ... Tesoro Refining & Marketing Company LLC Martinez Renewable Fuels Facility 150 Solano Way Martinez, CA 94553 August 6, 2024 VIA EMAIL TO COMPLIANCE@BAAQMD.GOV Mr. Jeffrey ...

Spare the Air Status

Última actualización: 08/11/2016