Búsqueda

  • 30884 Public Notice Chinese
    30884 Public Notice Chinese

    Sep 16, 2025 ... 公告 2025年[09] 月[16] 日 公告對象: 位於離下列提議中的新建或改建空氣污染源 5,000 英尺(1524 米)範圍內 的所有居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air District (灣區空氣管理局) 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #30884 : Eagle Rock Aggregates Oakland Terminal ...

    Read More
    (496 Kb PDF, 2 pgs)

    Sep 16, 2025 ... 公告 2025年[09] 月[16] 日 公告對象: 位於離下列提議中的新建或改建空氣污染源 5,000 英尺(1524 米)範圍內 的所有居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air District (灣區空氣管理局) 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #30884 : Eagle Rock Aggregates Oakland Terminal ...

  • 25797 Public Notice - Chinese Version
    25797 Public Notice - Chinese Version

    Jan 7, 2014 ... 公告 2014 年 1 月 10 日 公告對象: 在下列 學校註冊之兒童的家長或監護人 : Chinese American International School (中美國際學校 ) French American International School (法美國際學校 ) 位於離下列提議中的新建或改建空氣污染源 1,000 英呎範圍 內的所有居民及商戶。 ...

    Read More
    (283 Kb PDF, 2 pgs)

    Jan 7, 2014 ... 公告 2014 年 1 月 10 日 公告對象: 在下列 學校註冊之兒童的家長或監護人 : Chinese American International School (中美國際學校 ) French American International School (法美國際學校 ) 位於離下列提議中的新建或改建空氣污染源 1,000 英呎範圍 內的所有居民及商戶。 ...

  • 27284 Public Notice Chinese
    27284 Public Notice Chinese

    Nov 23, 2015 ... 公告 2015 年 12 月 8 日 公告對象: 在下列學校註冊之兒童的家長或監護人: Sacred Heart Cathedral Preparatory (聖心主教預備高中) 位於離下列提議中的新建或改建空氣污染源 1,000 英呎範圍 內的所有居民及商戶。 公告單位: 灣區空氣質素管理局 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #27284: 三 (3) ...

    Read More
    (309 Kb PDF, 2 pgs)

    Nov 23, 2015 ... 公告 2015 年 12 月 8 日 公告對象: 在下列學校註冊之兒童的家長或監護人: Sacred Heart Cathedral Preparatory (聖心主教預備高中) 位於離下列提議中的新建或改建空氣污染源 1,000 英呎範圍 內的所有居民及商戶。 公告單位: 灣區空氣質素管理局 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #27284: 三 (3) ...

  • 26427 Public Notice Chinese
    26427 Public Notice Chinese

    Mar 9, 2015 ... 公告告 20015 年 3 月 10 日 公告對象象: 在下列列學校註冊之兒童的家家長或監護人人: Pressidio Knollss School 位於離離下列提議中的新建或或改建空氣污污染源 1,0000 英呎範圍 內的所所有居民及商戶。 公告單位位: 灣區空空氣質素管理理局 公告事由由: 下列空空氣污染源的許可證申申請 #26427: ...

    Read More
    (171 Kb PDF, 2 pgs)

    Mar 9, 2015 ... 公告告 20015 年 3 月 10 日 公告對象象: 在下列列學校註冊之兒童的家家長或監護人人: Pressidio Knollss School 位於離離下列提議中的新建或或改建空氣污污染源 1,0000 英呎範圍 內的所所有居民及商戶。 公告單位位: 灣區空空氣質素管理理局 公告事由由: 下列空空氣污染源的許可證申申請 #26427: ...

  • 26654 Public Notice Chinese
    26654 Public Notice Chinese

    Feb 4, 2015 ... 公告告 20015 年 2 月 11 日 公告對象象: 在下列列學校註冊之兒童的家家長或監護人人: Buenaa Vista/Horaace Mann César Chhávez Elemeentary School Goldden Bridgess School 位於離離下列提議中的新建或或改建空氣污污染源 1,0000 英呎範圍 內的所所有居民及商戶。 公告單位位: ...

    Read More
    (194 Kb PDF, 2 pgs)

    Feb 4, 2015 ... 公告告 20015 年 2 月 11 日 公告對象象: 在下列列學校註冊之兒童的家家長或監護人人: Buenaa Vista/Horaace Mann César Chhávez Elemeentary School Goldden Bridgess School 位於離離下列提議中的新建或或改建空氣污污染源 1,0000 英呎範圍 內的所所有居民及商戶。 公告單位位: ...

  • 26571 Public Notice Chinese
    26571 Public Notice Chinese

    Dec 9, 2014 ... 公告告 20014 年 12 月 10 日 公告對象象: 在下列列學校註冊之兒童的家家長或監護人人: Hope LLutheran DDay School MM. Pauline Brown Elemmentary Schhool 位於離離下列提議中的新建或或改建空氣污污染源 1,0000 英呎範圍 內的所所有居民及商戶。 公告單位位: 灣區空空氣質素管理理局 ...

    Read More
    (202 Kb PDF, 2 pgs)

    Dec 9, 2014 ... 公告告 20014 年 12 月 10 日 公告對象象: 在下列列學校註冊之兒童的家家長或監護人人: Hope LLutheran DDay School MM. Pauline Brown Elemmentary Schhool 位於離離下列提議中的新建或或改建空氣污污染源 1,0000 英呎範圍 內的所所有居民及商戶。 公告單位位: 灣區空空氣質素管理理局 ...

  • 692505 & 703018 Public Notice Chinese Revised Comment Period
    692505 & 703018 Public Notice Chinese Revised Comment Period

    Jan 29, 2026 ... 公告 2026 年[01] 月[30] 日 公告對象: 在下列學校註冊之兒童的家長或監護人: Half Moon Bay High School 位於離下列提議中的新建或改建空氣污染源1,000 英尺(305 米)範圍內的 所有居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air District (灣區空氣局) 公告事由: 針對以下空氣污染源的許可證申請 ...

    Read More
    (472 Kb PDF, 2 pgs)

    Jan 29, 2026 ... 公告 2026 年[01] 月[30] 日 公告對象: 在下列學校註冊之兒童的家長或監護人: Half Moon Bay High School 位於離下列提議中的新建或改建空氣污染源1,000 英尺(305 米)範圍內的 所有居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air District (灣區空氣局) 公告事由: 針對以下空氣污染源的許可證申請 ...

  • RFI 2017-013 Technology Opportunities to Reduce GHG Emissions from Stationary Sources in the Bay Area
    RFI 2017-013 Technology Opportunities to Reduce GHG Emissions from Stationary Sources in the Bay Area

    Sep 14, 2017 ... September 14, 2017 Request for Information# 2017-013 Technology Opportunities to Reduce Greenhouse Gas Emissions from Stationary Sources in the Bay Area SECTION I – SUMMARY ...

    Read More
    (300 Kb PDF, 3 pgs)

    Sep 14, 2017 ... September 14, 2017 Request for Information# 2017-013 Technology Opportunities to Reduce Greenhouse Gas Emissions from Stationary Sources in the Bay Area SECTION I – SUMMARY ...

  • 26419 Public Notice Chinese
    26419 Public Notice Chinese

    Oct 15, 2014 ... 公告告 20014 年 10 月 17 日 公告對象象: 在下列列學校註冊之兒童的家家長或監護人人: Chinese Educatiion Center EElementaryy School(華華人教育中心心小學) Stt. Mary’s Scchool 位於離離下列提議中的新建或或改建空氣污污染源 1,0000 英呎範圍 內的所所有居民及商戶。 公告單位位: ...

    Read More
    (205 Kb PDF, 2 pgs)

    Oct 15, 2014 ... 公告告 20014 年 10 月 17 日 公告對象象: 在下列列學校註冊之兒童的家家長或監護人人: Chinese Educatiion Center EElementaryy School(華華人教育中心心小學) Stt. Mary’s Scchool 位於離離下列提議中的新建或或改建空氣污污染源 1,0000 英呎範圍 內的所所有居民及商戶。 公告單位位: ...

  • Board Minutes
    Board Minutes

    Mar 25, 2025 ... Bay Area Air Quality Management District 375 Beale Street, Suite 600 San Francisco, CA 94105 (415) 749-5073 Board of Directors Regular Meeting Wednesday, February 5, 2025 APPROVED ...

    Read More
    (214 Kb PDF, 9 pgs)

    Mar 25, 2025 ... Bay Area Air Quality Management District 375 Beale Street, Suite 600 San Francisco, CA 94105 (415) 749-5073 Board of Directors Regular Meeting Wednesday, February 5, 2025 APPROVED ...

  • Board Minutes
    Board Minutes

    Sep 16, 2020 ... Bay Area Air Quality Management District 375 Beale Street, Suite 600 San Francisco, CA 94105 (415) 749-5073 Board of Directors Regular Meeting Wednesday, July 15, 2020 APPROVED ...

    Read More
    (250 Kb PDF, 10 pgs)

    Sep 16, 2020 ... Bay Area Air Quality Management District 375 Beale Street, Suite 600 San Francisco, CA 94105 (415) 749-5073 Board of Directors Regular Meeting Wednesday, July 15, 2020 APPROVED ...

  • Declaración de Propósito y Objetivos
    Declaración de Propósito y Objetivos

    abr. 3, 2025 ... Plan de Reducción de Emisiones Comunitarias del Comité Directivo Comunitario de Bayview Hunters Point / Sureste de San Francisco I) Declaración de Propósito y Objetivos a. La Ley de la ...

    Read More
    (217 Kb PDF, 8 pgs)

    abr. 3, 2025 ... Plan de Reducción de Emisiones Comunitarias del Comité Directivo Comunitario de Bayview Hunters Point / Sureste de San Francisco I) Declaración de Propósito y Objetivos a. La Ley de la ...

  • ORDEN DEL DÍA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO ASESOR COMUNITARIO
    ORDEN DEL DÍA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO ASESOR COMUNITARIO

    may. 16, 2023 ... MESA DIRECTIVA CONSEJO ASESOR COMUNITARIO MIEMBROS DEL CONSEJO DR. JUAN AGUILERA HANA MENDOZA FERNANDO CAMPOS RIO MOLINA WILLIAM GOODWIN MAYRA PELAGIO SRA. MARGARET CHARLES REED GORDON DR.

    Read More
    (9 Mb PDF, 62 pgs)

    may. 16, 2023 ... MESA DIRECTIVA CONSEJO ASESOR COMUNITARIO MIEMBROS DEL CONSEJO DR. JUAN AGUILERA HANA MENDOZA FERNANDO CAMPOS RIO MOLINA WILLIAM GOODWIN MAYRA PELAGIO SRA. MARGARET CHARLES REED GORDON DR.

  • Charter Amendments
    Charter Amendments

    Charter 4. CSC Leadership 4.1 CSC Leadership Committee: The Leadership Committee will be constituido por un mínimo de dos miembros y un máximo de tres miembros from the CSC voting membership.

    Read More
    (87 Kb PDF, 4 pgs)

    Charter 4. CSC Leadership 4.1 CSC Leadership Committee: The Leadership Committee will be constituido por un mínimo de dos miembros y un máximo de tres miembros from the CSC voting membership.

  • RFP for CEQA Review Consultant Services
    RFP for CEQA Review Consultant Services

    Oct 4, 2016 ... October 4, 2016 Request for Proposals# 2016-004 Phillips 66 San Francisco Refinery Marine Terminal III Project CEQA Review Consultant Services SECTION I – SUMMARY ...

    Read More
    (333 Kb PDF, 10 pgs)

    Oct 4, 2016 ... October 4, 2016 Request for Proposals# 2016-004 Phillips 66 San Francisco Refinery Marine Terminal III Project CEQA Review Consultant Services SECTION I – SUMMARY ...

  • Meeting Minutes - August 25, 2025
    Meeting Minutes - August 25, 2025

    Borrador de actas – Richmond – North Richmond – San Pablo; Comité directivo del plan comunitario de redución de emisiones; 25 de agosto de 2025 Bay Area Air Quality Management District 375 ...

    Read More
    (170 Kb PDF, 11 pgs)

    Borrador de actas – Richmond – North Richmond – San Pablo; Comité directivo del plan comunitario de redución de emisiones; 25 de agosto de 2025 Bay Area Air Quality Management District 375 ...

  • Board MIntues
    Board MIntues

    jul. 15, 2020 ... Bay Area Air Quality Management District 375 Beale Street, Suite 600 San Francisco, CA 94105 (415) 749-5073 Board of Directors Special Meeting Wednesday, June 17, 2020 APPROVED ...

    Read More
    (159 Kb PDF, 4 pgs)

    jul. 15, 2020 ... Bay Area Air Quality Management District 375 Beale Street, Suite 600 San Francisco, CA 94105 (415) 749-5073 Board of Directors Special Meeting Wednesday, June 17, 2020 APPROVED ...

  • MBardet_Public Comment 2
    MBardet_Public Comment 2

    Dec 20, 2022 ... Kevin Oei Kathy Kerridge <(REDACTED)> From: Thursday, December 15, 2022 2:49 PM Sent: CommentsP66RodeoRenewed To: Subject: Fwd: [Benicia Resist!] Fwd: My comments on Rodeo Renewed Project Permitting ...

    Read More
    (1 Mb PDF, 13 pgs)

    Dec 20, 2022 ... Kevin Oei Kathy Kerridge <(REDACTED)> From: Thursday, December 15, 2022 2:49 PM Sent: CommentsP66RodeoRenewed To: Subject: Fwd: [Benicia Resist!] Fwd: My comments on Rodeo Renewed Project Permitting ...

  • MBardet_Public Comment 1
    MBardet_Public Comment 1

    Dec 20, 2022 ... Kevin Oei Marilyn Bardet <(REDACTED)> From: Friday, December 16, 2022 6:27 AM Sent: CommentsP66RodeoRenewed To: Subject: Fwd: [BAAQMD Network] My comments on Rodeo Renewed Project Permitting with ...

    Read More
    (1 Mb PDF, 12 pgs)

    Dec 20, 2022 ... Kevin Oei Marilyn Bardet <(REDACTED)> From: Friday, December 16, 2022 6:27 AM Sent: CommentsP66RodeoRenewed To: Subject: Fwd: [BAAQMD Network] My comments on Rodeo Renewed Project Permitting with ...

Spare the Air Status

Última actualización: 08/11/2016