搜尋

  • 719256 Public Notice Chinese
    719256 Public Notice Chinese

    Oct 23, 2025 ... 公告 2025年11 月04 日 公告對象: 位於離下列提議中的新建或改建空氣污染源1,000 英尺(305 米)範圍內的 所有居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air District (灣區空氣局) 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #719256: 應急備用 柴油引擎發電機 (Emergency Standby Diesel Generator ...

    Read More
    (602 Kb PDF, 2 pgs)

    Oct 23, 2025 ... 公告 2025年11 月04 日 公告對象: 位於離下列提議中的新建或改建空氣污染源1,000 英尺(305 米)範圍內的 所有居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air District (灣區空氣局) 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #719256: 應急備用 柴油引擎發電機 (Emergency Standby Diesel Generator ...

  • 717173 Public Notice Chinese
    717173 Public Notice Chinese

    Oct 6, 2025 ... 公告 2025年 10 月15 日 公告對象: 位於離下列提議中的新建或改建空氣污染源1,000 英尺(305 米)範圍內的 所有居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air District (灣區空氣局) 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #717173: 應急備用柴油發電機 (Emergency Standby Diesel Generator) ...

    Read More
    (486 Kb PDF, 2 pgs)

    Oct 6, 2025 ... 公告 2025年 10 月15 日 公告對象: 位於離下列提議中的新建或改建空氣污染源1,000 英尺(305 米)範圍內的 所有居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air District (灣區空氣局) 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #717173: 應急備用柴油發電機 (Emergency Standby Diesel Generator) ...

  • 719165 Public Notice Chinese
    719165 Public Notice Chinese

    Sep 12, 2025 ... 公告 2025年09 月25 日 公告對象: 位於離下列提議中的新建或改建空氣污染源1,000 英尺(305 米)範圍內的 所有居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air District (灣區空氣局) 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #719165: 應急備用 柴油引擎發電機 (Emergency Standby Diesel ...

    Read More
    (479 Kb PDF, 2 pgs)

    Sep 12, 2025 ... 公告 2025年09 月25 日 公告對象: 位於離下列提議中的新建或改建空氣污染源1,000 英尺(305 米)範圍內的 所有居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air District (灣區空氣局) 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #719165: 應急備用 柴油引擎發電機 (Emergency Standby Diesel ...

  • 712182 Public Notice Chinese
    712182 Public Notice Chinese

    Oct 6, 2025 ... 公告 2025年10 月17 日 公告對象: 位於離下列提議中的新建或改建空氣污染源1,000 英尺(305 米)範圍內的 所有居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air District (灣區空氣局) 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #712182: S-1 火管式鍋 爐,製造商:Cleaver-Brooks ,型號 ...

    Read More
    (493 Kb PDF, 2 pgs)

    Oct 6, 2025 ... 公告 2025年10 月17 日 公告對象: 位於離下列提議中的新建或改建空氣污染源1,000 英尺(305 米)範圍內的 所有居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air District (灣區空氣局) 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #712182: S-1 火管式鍋 爐,製造商:Cleaver-Brooks ,型號 ...

  • 714187 Public Notice Chinese
    714187 Public Notice Chinese

    Nov 13, 2025 ... 公告 2025年11 月20 日 公告對象: 位於離下列提議中的新建或改建空氣污染源1,000 英尺(305 米)範圍內的 所有居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air District (灣區空氣局) 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #714187: 一 (1) 台可攜式應 急備用消防泵 浦引擎 (1 Portable Emergency ...

    Read More
    (598 Kb PDF, 2 pgs)

    Nov 13, 2025 ... 公告 2025年11 月20 日 公告對象: 位於離下列提議中的新建或改建空氣污染源1,000 英尺(305 米)範圍內的 所有居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air District (灣區空氣局) 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #714187: 一 (1) 台可攜式應 急備用消防泵 浦引擎 (1 Portable Emergency ...

  • 31690 Public Notice Chinese
    31690 Public Notice Chinese

    Sep 22, 2025 ... 公告 2025年[09] 月[24] 日 公告對象: 位於離下列提議中的新建或改建空氣污染源1,000 英尺(305 米)範圍內的 所有居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air District (灣區空氣管理局) 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #31690 : 兩個 (2) 雙燃料 蒸煮器煤氣/天然氣鍋 爐 (Two (2) ...

    Read More
    (491 Kb PDF, 2 pgs)

    Sep 22, 2025 ... 公告 2025年[09] 月[24] 日 公告對象: 位於離下列提議中的新建或改建空氣污染源1,000 英尺(305 米)範圍內的 所有居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air District (灣區空氣管理局) 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #31690 : 兩個 (2) 雙燃料 蒸煮器煤氣/天然氣鍋 爐 (Two (2) ...

  • 30884 Public Notice Chinese
    30884 Public Notice Chinese

    Sep 16, 2025 ... 公告 2025年[09] 月[16] 日 公告對象: 位於離下列提議中的新建或改建空氣污染源 5,000 英尺(1524 米)範圍內 的所有居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air District (灣區空氣管理局) 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #30884 : Eagle Rock Aggregates Oakland Terminal ...

    Read More
    (496 Kb PDF, 2 pgs)

    Sep 16, 2025 ... 公告 2025年[09] 月[16] 日 公告對象: 位於離下列提議中的新建或改建空氣污染源 5,000 英尺(1524 米)範圍內 的所有居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air District (灣區空氣管理局) 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #30884 : Eagle Rock Aggregates Oakland Terminal ...

  • Agreement
    Agreement

    Jun 9, 2025 ... 1 PROPOSED SETTLEMENT AGREEMENT BY AND BETWEEN 2 THE BAY AREA AIR QUALITY MANAGMENT DISTRICT AND 3 CHEVRON PRODUCTS COMPANY (Notice of Violation 56287) 4 I. Background: Parties and ...

    Read More
    (14 Mb PDF, 288 pgs)

    Jun 9, 2025 ... 1 PROPOSED SETTLEMENT AGREEMENT BY AND BETWEEN 2 THE BAY AREA AIR QUALITY MANAGMENT DISTRICT AND 3 CHEVRON PRODUCTS COMPANY (Notice of Violation 56287) 4 I. Background: Parties and ...

  • Approved Chevron Quality Assurance Project Plan
    Approved Chevron Quality Assurance Project Plan

    Jun 5, 2025 ... Quality Assurance Project Plan Prepared by Prepared for Sonoma Technology, Inc. Chevron Products Company 1450 N. McDowell Blvd. Suite 200 100 Chevron Way Petaluma, CA 94954 ...

    Read More
    (1 Mb PDF, 55 pgs)

    Jun 5, 2025 ... Quality Assurance Project Plan Prepared by Prepared for Sonoma Technology, Inc. Chevron Products Company 1450 N. McDowell Blvd. Suite 200 100 Chevron Way Petaluma, CA 94954 ...

  • Semi-Annual monitoring Report 2024 B
    Semi-Annual monitoring Report 2024 B

    Jul 30, 2025 ... 45500 Fremont BLVD., Fremont CA 94578 P 650 681 5100 F 650 681 5101 st July 31 , 2025 Mr. Jeff Gove Director of Enforcement Bay Area Air Quality Management District 375 Beale ...

    Read More
    (350 Kb PDF, 9 pgs)

    Jul 30, 2025 ... 45500 Fremont BLVD., Fremont CA 94578 P 650 681 5100 F 650 681 5101 st July 31 , 2025 Mr. Jeff Gove Director of Enforcement Bay Area Air Quality Management District 375 Beale ...

  • 692505 & 703018 Public Notice Chinese
    692505 & 703018 Public Notice Chinese

    Dec 16, 2025 ... 公告 2025 年[12] 月[19] 日 公告對象: 在下列學校註冊之兒童的家長或監護人: Half Moon Bay High School 位於離下列提議中的新建或改建空氣污染源1,000 英尺(305 米)範圍內的 所有居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air District (灣區空氣局) 公告事由: 針對以下空氣污染源的許可證申請 ...

    Read More
    (489 Kb PDF, 2 pgs)

    Dec 16, 2025 ... 公告 2025 年[12] 月[19] 日 公告對象: 在下列學校註冊之兒童的家長或監護人: Half Moon Bay High School 位於離下列提議中的新建或改建空氣污染源1,000 英尺(305 米)範圍內的 所有居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air District (灣區空氣局) 公告事由: 針對以下空氣污染源的許可證申請 ...

  • Semi-Annual Monitoring Report 2025 A
    Semi-Annual Monitoring Report 2025 A

    Jan 29, 2026 ... January 30, 2026 Mr. Jeff Gove Director of Compliance and Enforcement Bay Area Air District 375 Beale Street, Suite 600 San Francisco, CA 94105 Attn. Title V Reports Transmitted by ...

    Read More
    (2 Mb PDF, 57 pgs)

    Jan 29, 2026 ... January 30, 2026 Mr. Jeff Gove Director of Compliance and Enforcement Bay Area Air District 375 Beale Street, Suite 600 San Francisco, CA 94105 Attn. Title V Reports Transmitted by ...

  • 社區指導委員會第13 次會議
    社區指導委員會第13 次會議

    十月 10, 2023 ... 東奧克蘭社區減排計劃 (CERP) 社區指導委員會第 13 次會議 2023 年 10 月 12 ...

    Read More
    (1 Mb PDF, 39 pgs)

    十月 10, 2023 ... 東奧克蘭社區減排計劃 (CERP) 社區指導委員會第 13 次會議 2023 年 10 月 12 ...

  • ac_min_101409
    ac_min_101409

    Nov 25, 2009 ... Bay Area Air Quality Management District 939 Ellis Street San Francisco, CA 94109 (415) 749-5000 APPROVED MINUTES Advisory Council Regular Meeting 9:00 a.m., Wednesday, October 14, 2009 ...

    Read More
    (76 Kb PDF, 17 pgs)

    Nov 25, 2009 ... Bay Area Air Quality Management District 939 Ellis Street San Francisco, CA 94109 (415) 749-5000 APPROVED MINUTES Advisory Council Regular Meeting 9:00 a.m., Wednesday, October 14, 2009 ...

  • Public Comment Emails and Comment Letters (Redacted)
    Public Comment Emails and Comment Letters (Redacted)

    Feb 9, 2024 ... Attachment 3 Copies of All Emails and Comment Letters From: Angel Chavarin To: Air Quality Planning Subject: (PTCA) path to clear air Date: Thursday, January 18, 2024 12:03:06 PM [You don't often get ...

    Read More
    (9 Mb PDF, 86 pgs)

    Feb 9, 2024 ... Attachment 3 Copies of All Emails and Comment Letters From: Angel Chavarin To: Air Quality Planning Subject: (PTCA) path to clear air Date: Thursday, January 18, 2024 12:03:06 PM [You don't often get ...

  • Response to Comments
    Response to Comments

    Feb 20, 2026 ... Response to Public Comments February 2026 Response to Public Comments Draft Right to Breathe: East Oakland Community Air Quality Justice Plan On November 3, 2025, the Air District and the ...

    Read More
    (39 Mb PDF, 351 pgs)

    Feb 20, 2026 ... Response to Public Comments February 2026 Response to Public Comments Draft Right to Breathe: East Oakland Community Air Quality Justice Plan On November 3, 2025, the Air District and the ...

  • Council Agenda
    Council Agenda

    五月 20, 2024 ... 董事會 社區諮詢委員會 2024年5月16 日委員 FERNANDO CAMPOS RIO MOLINA WILLIAM GOODWIN MAYRA PELAGIO MS. MARGARET GORDON DR. JEFF RITTERMAN KEVIN ARIEANN HARRISON JOHN RUANO HERNANDEZ KEVIN JEFFERSON JOY ...

    Read More
    (4 Mb PDF, 83 pgs)

    五月 20, 2024 ... 董事會 社區諮詢委員會 2024年5月16 日委員 FERNANDO CAMPOS RIO MOLINA WILLIAM GOODWIN MAYRA PELAGIO MS. MARGARET GORDON DR. JEFF RITTERMAN KEVIN ARIEANN HARRISON JOHN RUANO HERNANDEZ KEVIN JEFFERSON JOY ...

  • Semi-Annual Monitoring Report 2025 A
    Semi-Annual Monitoring Report 2025 A

    Jan 30, 2026 ... 45500 Fremont BLVD., Fremont CA 94578 P 650 681 5100 F 650 681 5101 January 31st, 2026 Mr. Jeff Gove Director of Enforcement Bay Area Air Quality Management District 375 Beale ...

    Read More
    (911 Kb PDF, 39 pgs)

    Jan 30, 2026 ... 45500 Fremont BLVD., Fremont CA 94578 P 650 681 5100 F 650 681 5101 January 31st, 2026 Mr. Jeff Gove Director of Enforcement Bay Area Air Quality Management District 375 Beale ...

  • Semi-Annual Monitoring Report 2024 B
    Semi-Annual Monitoring Report 2024 B

    Aug 29, 2025 ... Vasco Road Landfill 4001 N. Vasco Road, Livermore, CA 94551 o 925.447.0491 republicservices.com Director of Compliance and Enforcement Bay Area Air District 375 Beale Street, Suite 600 San ...

    Read More
    (12 Mb PDF, 161 pgs)

    Aug 29, 2025 ... Vasco Road Landfill 4001 N. Vasco Road, Livermore, CA 94551 o 925.447.0491 republicservices.com Director of Compliance and Enforcement Bay Area Air District 375 Beale Street, Suite 600 San ...

  • 董事會
    董事會

    九月 18, 2024 ... 董事會 社區諮詢委員會 2024 年 9 月 19 日 委員會成員 FERNANDO CAMPOS JEFF RITTERMAN 博士 WILLIAM GOODWIN KEVIN RUANO HERNANDEZ MARGARET GORDON 女士 FAGAMALAMA VIOLET SAENA ARIEANN HARRISON KEN ...

    Read More
    (2 Mb PDF, 142 pgs)

    九月 18, 2024 ... 董事會 社區諮詢委員會 2024 年 9 月 19 日 委員會成員 FERNANDO CAMPOS JEFF RITTERMAN 博士 WILLIAM GOODWIN KEVIN RUANO HERNANDEZ MARGARET GORDON 女士 FAGAMALAMA VIOLET SAENA ARIEANN HARRISON KEN ...

Spare the Air Status

上次更新: 2016/11/8