Búsqueda

  • 675099 Public Notice Chinese
    675099 Public Notice Chinese

    Aug 15, 2023 ... 公告 2023 年 08 月 17 日 公告對象: 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英呎範圍內的所 有居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air Quality Management District (灣區空氣質素管理局) 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #675099: 應急 備用柴油引 擎 (Emergency ...

    Read More
    (333 Kb PDF, 2 pgs)

    Aug 15, 2023 ... 公告 2023 年 08 月 17 日 公告對象: 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英呎範圍內的所 有居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air Quality Management District (灣區空氣質素管理局) 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #675099: 應急 備用柴油引 擎 (Emergency ...

  • 676820 Public Notice Chinese
    676820 Public Notice Chinese

    Aug 15, 2023 ... 公告 2023 年 08 月 17 日 公告對象: 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英呎範圍內的所 有居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air Quality Management District (灣區空氣質素管理局) 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #676820: 應急 備用柴油發 電機 (Emergency ...

    Read More
    (326 Kb PDF, 2 pgs)

    Aug 15, 2023 ... 公告 2023 年 08 月 17 日 公告對象: 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英呎範圍內的所 有居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air Quality Management District (灣區空氣質素管理局) 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #676820: 應急 備用柴油發 電機 (Emergency ...

  • 673984 Public Notice Chinese
    673984 Public Notice Chinese

    abr. 11, 2023 ... 公告 2023 年 04 月 13 日 公告對象: 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英呎範圍 內的所 有居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air Quality Management District (灣區空氣質素管理局) 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #673984: 固定式應 急柴油發動機 - 發 電機組 ...

    Read More
    (341 Kb PDF, 2 pgs)

    abr. 11, 2023 ... 公告 2023 年 04 月 13 日 公告對象: 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英呎範圍 內的所 有居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air Quality Management District (灣區空氣質素管理局) 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #673984: 固定式應 急柴油發動機 - 發 電機組 ...

  • 672234 Public Notice Chinese
    672234 Public Notice Chinese

    Jul 6, 2023 ... 公告 2023 年 7 月 7 日 公告對象: 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英呎範圍內的所 有居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air Quality Management District (灣區空氣質素管理局) 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #672234: 台 應 急 備 用柴 油 發 電 機組 ...

    Read More
    (333 Kb PDF, 2 pgs)

    Jul 6, 2023 ... 公告 2023 年 7 月 7 日 公告對象: 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英呎範圍內的所 有居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air Quality Management District (灣區空氣質素管理局) 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #672234: 台 應 急 備 用柴 油 發 電 機組 ...

  • 31232 Public Notice Chinese
    31232 Public Notice Chinese

    mar. 21, 2023 ... 公告 2023 年 3 月 30 日 公告對象: 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英呎範圍內的所 有居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air Quality Management District (灣區空氣質素管理局) 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #31232: 應急 備用柴油發 電機 (Emergency ...

    Read More
    (443 Kb PDF, 2 pgs)

    mar. 21, 2023 ... 公告 2023 年 3 月 30 日 公告對象: 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英呎範圍內的所 有居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air Quality Management District (灣區空氣質素管理局) 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #31232: 應急 備用柴油發 電機 (Emergency ...

  • 669835 Public Notice Chinese
    669835 Public Notice Chinese

    jun. 12, 2023 ... 公告 2023 年 06 月 14 日 公告對象: 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英呎範圍 內的所 有居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air Quality Management District (灣區 空氣質素管理局) 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #669835: 應 急備 用柴油 發電 機 ...

    Read More
    (436 Kb PDF, 2 pgs)

    jun. 12, 2023 ... 公告 2023 年 06 月 14 日 公告對象: 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英呎範圍 內的所 有居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air Quality Management District (灣區 空氣質素管理局) 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #669835: 應 急備 用柴油 發電 機 ...

  • 676886 Public Notice Chinese
    676886 Public Notice Chinese

    sep. 13, 2023 ... 公告 2023 年 09 月 22 日 公告對象: 在下列學校註冊之兒童的家長或監護人 : Yu Ming Charter School Upper School (育明中英雙語學院) 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英呎範圍 內的所 有居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air Quality Management ...

    Read More
    (340 Kb PDF, 2 pgs)

    sep. 13, 2023 ... 公告 2023 年 09 月 22 日 公告對象: 在下列學校註冊之兒童的家長或監護人 : Yu Ming Charter School Upper School (育明中英雙語學院) 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英呎範圍 內的所 有居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air Quality Management ...

  • 704575 Public Notice Chinese
    704575 Public Notice Chinese

    Oct 2, 2024 ... 公告 2024 年 10 月 8 日 公告對象: 在下列學校註冊的兒童的家長或監護人: Fusion Academy Palo Alto School Silicon Valley International School 位於距離下列提議中的新建或改建空氣污染源 1,000 英尺(305 米)範圍內的所有居民及商戶。 公告機構: 灣區空氣品質管理局 ...

    Read More
    (201 Kb PDF, 2 pgs)

    Oct 2, 2024 ... 公告 2024 年 10 月 8 日 公告對象: 在下列學校註冊的兒童的家長或監護人: Fusion Academy Palo Alto School Silicon Valley International School 位於距離下列提議中的新建或改建空氣污染源 1,000 英尺(305 米)範圍內的所有居民及商戶。 公告機構: 灣區空氣品質管理局 ...

  • 31157 Public Notice Chinese
    31157 Public Notice Chinese

    nov. 14, 2022 ... 公告 2022年 11月 15日 公告對象: 位於 離下 列提議中的新建或改建空氣污染源 1,000 英呎範圍 內的所 有居民及商 戶。 公告單位: 灣區空氣質素管理局 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #31157: Rodeo Renewed 項目 Phillips 66 Company - San Francisco Refinery 1380 ...

    Read More
    (926 Kb PDF, 2 pgs)

    nov. 14, 2022 ... 公告 2022年 11月 15日 公告對象: 位於 離下 列提議中的新建或改建空氣污染源 1,000 英呎範圍 內的所 有居民及商 戶。 公告單位: 灣區空氣質素管理局 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #31157: Rodeo Renewed 項目 Phillips 66 Company - San Francisco Refinery 1380 ...

  • Approving the Adoption of the California Employers' Pension Prefunding Trust Fund (CEPPT) Administered by California Public Employees' Retirement System (CALPERS)
    Approving the Adoption of the California Employers' Pension Prefunding Trust Fund (CEPPT) Administered by California Public Employees' Retirement System (CALPERS)

    Jun 1, 2022 ... BAY AREA AIR QUALITY MANAGEMENT DISTRICT RESOLUTION NO. 2022-09 RESOLUTION OF THE GOVERNING BOARD OF DIRECTORS OF THE BAY AREA AIR QUALITY MANAGEMENT DISTRICT APPROVING THE ADOPTION OFTHE ...

    Read More
    (470 Kb PDF, 2 pgs)

    Jun 1, 2022 ... BAY AREA AIR QUALITY MANAGEMENT DISTRICT RESOLUTION NO. 2022-09 RESOLUTION OF THE GOVERNING BOARD OF DIRECTORS OF THE BAY AREA AIR QUALITY MANAGEMENT DISTRICT APPROVING THE ADOPTION OFTHE ...

  • April 3 2019 Meeting Summary
    April 3 2019 Meeting Summary

    West Oakland Environmental Indicators Project West Oakland Community Action Plan Steering Committee Meeting #9 Wednesday, April 3, 2019, 6:00 PM - 8:30 PM West Oakland Senior ...

    Read More
    (218 Kb PDF, 2 pgs)

    West Oakland Environmental Indicators Project West Oakland Community Action Plan Steering Committee Meeting #9 Wednesday, April 3, 2019, 6:00 PM - 8:30 PM West Oakland Senior ...

  • Appendix B: Methodology for Derivation of Toxic Air Contaminant (TAC) Trigger Levels
    Appendix B: Methodology for Derivation of Toxic Air Contaminant (TAC) Trigger Levels

    oct. 26, 2016 ... Staff Report July 2016 Appendix B Methodology for Derivation of Toxic Air Contaminant (TAC) Trigger Levels ...

    Read More
    (193 Kb PDF, 11 pgs)

    oct. 26, 2016 ... Staff Report July 2016 Appendix B Methodology for Derivation of Toxic Air Contaminant (TAC) Trigger Levels ...

  • March 11 2019 Meeting Summary
    March 11 2019 Meeting Summary

    West Oakland Environmental Indicators Project West Oakland Community Action Plan Steering Committee Meeting #8 Monday, March 11, 2019, 6:00 PM - 9:00 PM Alameda County Public ...

    Read More
    (242 Kb PDF, 3 pgs)

    West Oakland Environmental Indicators Project West Oakland Community Action Plan Steering Committee Meeting #8 Monday, March 11, 2019, 6:00 PM - 9:00 PM Alameda County Public ...

  • Agreement
    Agreement

    SETILE.MENT AGREEMENT AND RELEASE BETWEEN 2 THE BAY AREA AIR QUALITY MANAGEMENT DISTRICT AND 3 CHEMTRADE WEST US LLC 4 1. The BAY AREA AIR QUALITY MANAGEMENT DISTRICT ("DISTRICT") and 5 6 ...

    Read More
    (614 Kb PDF, 4 pgs)

    SETILE.MENT AGREEMENT AND RELEASE BETWEEN 2 THE BAY AREA AIR QUALITY MANAGEMENT DISTRICT AND 3 CHEMTRADE WEST US LLC 4 1. The BAY AREA AIR QUALITY MANAGEMENT DISTRICT ("DISTRICT") and 5 6 ...

  • Meeting Slides
    Meeting Slides

    Mar 9, 2023 ... WOCAP Steering Committee November 2, 2022 West Oakland Community Action ...

    Read More
    (7 Mb PDF, 31 pgs)

    Mar 9, 2023 ... WOCAP Steering Committee November 2, 2022 West Oakland Community Action ...

  • CAC 2024-2025 Work Plan
    CAC 2024-2025 Work Plan

    Calendar of Agenda Items (2024-2025 Work Plan) CAC Member Lead-Subject to Work Plan Agenda Items Potential Recommendations (or Information Only) Description of Community Benefit Change Develop ...

    Read More
    (51 Kb PDF, 2 pgs)

    Calendar of Agenda Items (2024-2025 Work Plan) CAC Member Lead-Subject to Work Plan Agenda Items Potential Recommendations (or Information Only) Description of Community Benefit Change Develop ...

  • 709283 Permit Evaluation
    709283 Permit Evaluation

    mar. 20, 2025 ... Montezuma Wetlands, LLC Facility #: 203615 Application #: 709283 DRAFT ENGINEERING EVALUATION Montezuma Wetlands, LLC 1285 Collinsville Road, Suisun City, CA 94585 Facility #: 203615 ...

    Read More
    (1 Mb PDF, 37 pgs)

    mar. 20, 2025 ... Montezuma Wetlands, LLC Facility #: 203615 Application #: 709283 DRAFT ENGINEERING EVALUATION Montezuma Wetlands, LLC 1285 Collinsville Road, Suisun City, CA 94585 Facility #: 203615 ...

  • HHHHHH Instructions
    HHHHHH Instructions

    may. 2, 2008 ... What Is The Compliance Date? You can also contact your Regional EPA air toxics United States April 2008 office at the ...

    Read More
    (69 Kb PDF, 2 pgs)

    may. 2, 2008 ... What Is The Compliance Date? You can also contact your Regional EPA air toxics United States April 2008 office at the ...

  • Stipulated Conditional Order for Abatement
    Stipulated Conditional Order for Abatement

    Apr 12, 2022 ... FILED f APR U 2022 1 HEA!llNG OOAAO FILED !JAY AREA AIR OUAUTY 2 MANAGEMENT o•r111r;T This stamp is for the 3 I FEB t4 zozz l Stipulated Conditional Order for Abatement 4 HEAA1NG 8(WW) ...

    Read More
    (2 Mb PDF, 7 pgs)

    Apr 12, 2022 ... FILED f APR U 2022 1 HEA!llNG OOAAO FILED !JAY AREA AIR OUAUTY 2 MANAGEMENT o•r111r;T This stamp is for the 3 I FEB t4 zozz l Stipulated Conditional Order for Abatement 4 HEAA1NG 8(WW) ...

  • Method 44A - Determination of Reduced Sulfur Gases and Sulfur Dioxide in Effluent Samples by Gas Chromatographic Method
    Method 44A - Determination of Reduced Sulfur Gases and Sulfur Dioxide in Effluent Samples by Gas Chromatographic Method

    may. 15, 2009 ... METHOD 44A DETERMINATION OF REDUCED SULFUR GASES AND SULFUR DIOXIDE IN A GASEOUS MATRIX USING THE SULFUR CHEMILUMINESCENCE DETECTOR REF: Reg. 7-303 ...

    Read More
    (109 Kb PDF, 8 pgs)

    may. 15, 2009 ... METHOD 44A DETERMINATION OF REDUCED SULFUR GASES AND SULFUR DIOXIDE IN A GASEOUS MATRIX USING THE SULFUR CHEMILUMINESCENCE DETECTOR REF: Reg. 7-303 ...

Spare the Air Status

Última actualización: 08/11/2016