Búsqueda

  • 679552 Public Notice Chinese
    679552 Public Notice Chinese

    oct. 3, 2023 ... 公告 2023 年 10 月 5 日 公告對象: 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英呎範圍 內的所有 居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air Quality Management District (灣區空氣質素管理局) 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #679552: 兩台固定 式應急柴油引擎 - 發電機組 (Two ...

    Read More
    (349 Kb PDF, 2 pgs)

    oct. 3, 2023 ... 公告 2023 年 10 月 5 日 公告對象: 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英呎範圍 內的所有 居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air Quality Management District (灣區空氣質素管理局) 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #679552: 兩台固定 式應急柴油引擎 - 發電機組 (Two ...

  • 684118 Public Notice Chinese
    684118 Public Notice Chinese

    May 22, 2024 ... 公告 2024 年 5 月 31 日 公告對象: 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英呎範圍內的所有 居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air Quality Management District (灣區空氣質素管理局) 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #684118: 應急備用 柴油發電機組 (Emergency ...

    Read More
    (344 Kb PDF, 2 pgs)

    May 22, 2024 ... 公告 2024 年 5 月 31 日 公告對象: 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英呎範圍內的所有 居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air Quality Management District (灣區空氣質素管理局) 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #684118: 應急備用 柴油發電機組 (Emergency ...

  • 679129 Public Notice Chinese
    679129 Public Notice Chinese

    ago. 9, 2023 ... 公告 2023 年 8 月 11 日 公告對象: 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英呎範圍內的所 有居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air Quality Management District (灣區空氣質素管理局) 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #679129: 應 急 備 用 柴油 發 電 機 ...

    Read More
    (377 Kb PDF, 2 pgs)

    ago. 9, 2023 ... 公告 2023 年 8 月 11 日 公告對象: 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英呎範圍內的所 有居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air Quality Management District (灣區空氣質素管理局) 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #679129: 應 急 備 用 柴油 發 電 機 ...

  • 682764 Public Notice Chinese
    682764 Public Notice Chinese

    sep. 24, 2024 ... 公告 2024 年 9 月 26 日 公告對象: 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英呎範圍內的所有 居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air Quality Management District (灣區空氣質素管理局) 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #682764: 應急 備用柴油發 電機組 (Emergency ...

    Read More
    (322 Kb PDF, 2 pgs)

    sep. 24, 2024 ... 公告 2024 年 9 月 26 日 公告對象: 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英呎範圍內的所有 居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air Quality Management District (灣區空氣質素管理局) 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #682764: 應急 備用柴油發 電機組 (Emergency ...

  • 669835 Public Notice Chinese
    669835 Public Notice Chinese

    jun. 12, 2023 ... 公告 2023 年 06 月 14 日 公告對象: 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英呎範圍 內的所 有居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air Quality Management District (灣區 空氣質素管理局) 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #669835: 應 急備 用柴油 發電 機 ...

    Read More
    (436 Kb PDF, 2 pgs)

    jun. 12, 2023 ... 公告 2023 年 06 月 14 日 公告對象: 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英呎範圍 內的所 有居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air Quality Management District (灣區 空氣質素管理局) 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #669835: 應 急備 用柴油 發電 機 ...

  • 31081 Public Notice Chinese
    31081 Public Notice Chinese

    feb. 27, 2024 ... 公告 2024 年 3 月 1 日 公告對象: 在下列學校註冊之兒童的家長或監護人 : Redding Elementary School Spring Valley Science School 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英呎範圍 內的所有 居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air Quality Management ...

    Read More
    (342 Kb PDF, 2 pgs)

    feb. 27, 2024 ... 公告 2024 年 3 月 1 日 公告對象: 在下列學校註冊之兒童的家長或監護人 : Redding Elementary School Spring Valley Science School 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英呎範圍 內的所有 居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air Quality Management ...

  • 660549 Public Notice Chinese
    660549 Public Notice Chinese

    ago. 15, 2022 ... 公告 2022 年 8 月 17 日 公告對象: 位於離下列提議中的新建或改建空氣污染源 1,000 英呎範圍內的所 有居民及商戶。 公告單位: 灣區空氣質素管理局 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請#660549: 緊 急備 用柴油 發電 機 (Emergency Standby Diesel Generator) BA22522B - BA522 ...

    Read More
    (528 Kb PDF, 2 pgs)

    ago. 15, 2022 ... 公告 2022 年 8 月 17 日 公告對象: 位於離下列提議中的新建或改建空氣污染源 1,000 英呎範圍內的所 有居民及商戶。 公告單位: 灣區空氣質素管理局 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請#660549: 緊 急備 用柴油 發電 機 (Emergency Standby Diesel Generator) BA22522B - BA522 ...

  • 31255 Public Notice Chinese
    31255 Public Notice Chinese

    ago. 22, 2022 ... 公告 2022 年 8 月 23 日 公告對象: 位於離下列提議中的新建或改建空氣污染源 1,000 英呎範圍內的所 有居民及商戶。 公告單位: 灣區空氣質素管理局 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請#31255: 新 設施/7 台緊急柴油 備用 發電 機 (New Facility / 7 Emergency Diesel Backup Generators) ...

    Read More
    (463 Kb PDF, 2 pgs)

    ago. 22, 2022 ... 公告 2022 年 8 月 23 日 公告對象: 位於離下列提議中的新建或改建空氣污染源 1,000 英呎範圍內的所 有居民及商戶。 公告單位: 灣區空氣質素管理局 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請#31255: 新 設施/7 台緊急柴油 備用 發電 機 (New Facility / 7 Emergency Diesel Backup Generators) ...

  • 709283 Public Notice Chinese
    709283 Public Notice Chinese

    mar. 23, 2025 ... 公告 2025年[03] 月[25] 日 公告對象: 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源1,000 英尺(305 米)範 圍內的所有居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air Quality Management District (灣區空氣質素管理局) 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #709283: S-1 受污染沉積物修復 - ...

    Read More
    (385 Kb PDF, 2 pgs)

    mar. 23, 2025 ... 公告 2025年[03] 月[25] 日 公告對象: 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源1,000 英尺(305 米)範 圍內的所有居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air Quality Management District (灣區空氣質素管理局) 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #709283: S-1 受污染沉積物修復 - ...

  • 31761 Public Notice Chinese
    31761 Public Notice Chinese

    dic. 5, 2023 ... 公告 2023 年 12 月 7 日 公告對象: 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英呎範圍 內的所有 居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air Quality Management District (灣區空氣質素管理局) 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #31761: 儲存罐 S-14、S-15 及 S-16 的 材料改製 ...

    Read More
    (435 Kb PDF, 2 pgs)

    dic. 5, 2023 ... 公告 2023 年 12 月 7 日 公告對象: 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英呎範圍 內的所有 居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air Quality Management District (灣區空氣質素管理局) 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #31761: 儲存罐 S-14、S-15 及 S-16 的 材料改製 ...

  • 32088 Public Notice Chinese
    32088 Public Notice Chinese

    abr. 14, 2025 ... 公告 2025年[04] 月[16] 日 公告對象: 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源1,000 英尺(305 米)範 圍內的所有居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air Quality Management District (灣區空氣質素管理局) 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #32088: 鐳 射金 屬切割 機 (Laser ...

    Read More
    (363 Kb PDF, 2 pgs)

    abr. 14, 2025 ... 公告 2025年[04] 月[16] 日 公告對象: 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源1,000 英尺(305 米)範 圍內的所有居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air Quality Management District (灣區空氣質素管理局) 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #32088: 鐳 射金 屬切割 機 (Laser ...

  • 31318 Public Notice Chinese
    31318 Public Notice Chinese

    dic. 19, 2023 ... 公告 2023 年 12 月 21 日 公告對象: 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英呎範圍內的所有 居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air Quality Management District (灣區空氣質素管理局) 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #31318: 新型 沼氣調節系 統與新型熱 電聯產 發動 機 (New ...

    Read More
    (358 Kb PDF, 2 pgs)

    dic. 19, 2023 ... 公告 2023 年 12 月 21 日 公告對象: 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英呎範圍內的所有 居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air Quality Management District (灣區空氣質素管理局) 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #31318: 新型 沼氣調節系 統與新型熱 電聯產 發動 機 (New ...

  • 31578 Public Notice Chinese
    31578 Public Notice Chinese

    nov. 14, 2022 ... 公告 2023 年 1 月 6 日 公告對象: 公告對象: 在下列學校註冊之兒童的家長或監護人 : Tenderloin Community S.F. County Civic Center Secondary Sacred Heart Cathedral Preparatory 位於 離下列提議中的新建或改建空氣 污 染源 1,000 英呎範圍 內的所 有居民及商 戶 。 ...

    Read More
    (389 Kb PDF, 2 pgs)

    nov. 14, 2022 ... 公告 2023 年 1 月 6 日 公告對象: 公告對象: 在下列學校註冊之兒童的家長或監護人 : Tenderloin Community S.F. County Civic Center Secondary Sacred Heart Cathedral Preparatory 位於 離下列提議中的新建或改建空氣 污 染源 1,000 英呎範圍 內的所 有居民及商 戶 。 ...

  • 686579 Public Notice Chinese
    686579 Public Notice Chinese

    Sep 14, 2023 ... 公告 2023 年 9 月 20 日 公告對象: 在下列學校註冊之兒童的家長或監護人 : Lila Bringhurst Elementary 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英呎範圍內的所有 居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air Quality Management District (灣區空氣質素管理局) 公告事由: ...

    Read More
    (331 Kb PDF, 2 pgs)

    Sep 14, 2023 ... 公告 2023 年 9 月 20 日 公告對象: 在下列學校註冊之兒童的家長或監護人 : Lila Bringhurst Elementary 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英呎範圍內的所有 居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air Quality Management District (灣區空氣質素管理局) 公告事由: ...

  • Regulation 11, Rule 16 Perchloroethylene and Synthetic Solvent Dry Cleaning Operations
    Regulation 11, Rule 16 Perchloroethylene and Synthetic Solvent Dry Cleaning Operations

    Jun 12, 2009 ... BAY AREA AIR QUALITY MANAGEMENT DISTRICT  Regulation 11, Rule 16 Perchloroethylene and Synthetic Solvent Dry Cleaning Operations  Workshop Report  Prepared by  Marc Nash  Toxic Evaluation ...

    Read More
    (410 Kb PDF, 23 pgs)

    Jun 12, 2009 ... BAY AREA AIR QUALITY MANAGEMENT DISTRICT  Regulation 11, Rule 16 Perchloroethylene and Synthetic Solvent Dry Cleaning Operations  Workshop Report  Prepared by  Marc Nash  Toxic Evaluation ...

  • Board Agenda
    Board Agenda

    Nov 23, 2021 ... BOARD OF DIRECTORS SPECIAL MEETING DECEMBER 1, 2021 THIS MEETING WILL BE CONDUCTED UNDER PROCEDURES AUTHORIZED BY ASSEMBLY BILL 361 • THE PUBLIC MAY OBSERVE THIS MEETING ...

    Read More
    (2 Mb PDF, 243 pgs)

    Nov 23, 2021 ... BOARD OF DIRECTORS SPECIAL MEETING DECEMBER 1, 2021 THIS MEETING WILL BE CONDUCTED UNDER PROCEDURES AUTHORIZED BY ASSEMBLY BILL 361 • THE PUBLIC MAY OBSERVE THIS MEETING ...

  • Semi-Annual Monitoring Report 2021 A
    Semi-Annual Monitoring Report 2021 A

    Jan 31, 2022 ... January 31, 2022 Mr. Jeff Gove, Director of Compliance and Enforcement Bay Area Air Quality Management District 375 Beale Street, Suite 600 San Francisco, CA 94105 Attn. Title V ...

    Read More
    (5 Mb PDF, 47 pgs)

    Jan 31, 2022 ... January 31, 2022 Mr. Jeff Gove, Director of Compliance and Enforcement Bay Area Air Quality Management District 375 Beale Street, Suite 600 San Francisco, CA 94105 Attn. Title V ...

  • Semi-Annual Monitoring Report 2022 B
    Semi-Annual Monitoring Report 2022 B

    Jan 27, 2023 ... Kirby Canyon Recycling & Disposal Facility 910 Coyote Creek Golf Drive PO Box 1870 Morgan Hill, California 95037 T: 408.779.2206 January 25, 2023 Director of ...

    Read More
    (27 Mb PDF, 359 pgs)

    Jan 27, 2023 ... Kirby Canyon Recycling & Disposal Facility 910 Coyote Creek Golf Drive PO Box 1870 Morgan Hill, California 95037 T: 408.779.2206 January 25, 2023 Director of ...

  • Semi-Annual Monitoring Report 2024 A
    Semi-Annual Monitoring Report 2024 A

    Nov 27, 2024 ... REDWOOD LANDFILL, INC. P.O. Box 793 8950 Redwood Highway Novato, CA 94948 (415) 892-2851 (415) 898-1354 Fax November 29, 2024 Director of Compliance and Enforcement Director of the ...

    Read More
    (17 Mb PDF, 546 pgs)

    Nov 27, 2024 ... REDWOOD LANDFILL, INC. P.O. Box 793 8950 Redwood Highway Novato, CA 94948 (415) 892-2851 (415) 898-1354 Fax November 29, 2024 Director of Compliance and Enforcement Director of the ...

  • Semi-Annual Monitoring Report 2021 A
    Semi-Annual Monitoring Report 2021 A

    Nov 26, 2021 ... REDWOOD LANDFILL, INC. P.O. Box 793 8950 Redwood Highway Novato, CA 94948 (415) 892-2851 (415) 898-1354 Fax November 26, 2021 Director of Compliance and Enforcement Director of the ...

    Read More
    (26 Mb PDF, 643 pgs)

    Nov 26, 2021 ... REDWOOD LANDFILL, INC. P.O. Box 793 8950 Redwood Highway Novato, CA 94948 (415) 892-2851 (415) 898-1354 Fax November 26, 2021 Director of Compliance and Enforcement Director of the ...

Spare the Air Status

Última actualización: 08/11/2016