Búsqueda

  • 672182 Public Notice Chinese
    672182 Public Notice Chinese

    Jun 14, 2023 ... 公告 2023 年 6 月 16 日 公告對象: 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英呎範圍內的所 有居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air Quality Management District (灣區空氣質素管理局) 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #672182: 固定 式應急柴油 發動機 - 發電機組 ...

    Read More
    (334 Kb PDF, 2 pgs)

    Jun 14, 2023 ... 公告 2023 年 6 月 16 日 公告對象: 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英呎範圍內的所 有居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air Quality Management District (灣區空氣質素管理局) 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #672182: 固定 式應急柴油 發動機 - 發電機組 ...

  • 667680 Public Notice Chinese
    667680 Public Notice Chinese

    Mar 27, 2023 ... 公告 2023 年 03 月 29 日 公告對象: 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英呎範圍 內的所 有居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air Quality Management District (灣區空氣質素管理局) 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #667680: 四台固定 式應急柴油發動機 - 發電機組 ...

    Read More
    (337 Kb PDF, 2 pgs)

    Mar 27, 2023 ... 公告 2023 年 03 月 29 日 公告對象: 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英呎範圍 內的所 有居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air Quality Management District (灣區空氣質素管理局) 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #667680: 四台固定 式應急柴油發動機 - 發電機組 ...

  • 664972 Public Notice Chinese
    664972 Public Notice Chinese

    Mar 7, 2023 ... 公告 2023 年 3 月 10 日 公告對象: 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英呎範圍內的所 有居民及商戶。 公告單位: 灣區空氣質素管理局 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #664972: 緊急 備用柴油發 電機組 Comcast of San Leandro, Inc 23525 Clawiter Road, ...

    Read More
    (316 Kb PDF, 2 pgs)

    Mar 7, 2023 ... 公告 2023 年 3 月 10 日 公告對象: 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英呎範圍內的所 有居民及商戶。 公告單位: 灣區空氣質素管理局 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #664972: 緊急 備用柴油發 電機組 Comcast of San Leandro, Inc 23525 Clawiter Road, ...

  • 664909 Public Notice Chinese
    664909 Public Notice Chinese

    Dec 15, 2022 ... 公告 2022 年 12 月 20 日 公告對象: 在下列學校註冊之兒童的家長或監護人 : California Crosspoint Academy 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英呎範圍 內的所 有居民及商戶。 公告單位: 灣區空氣質素管理局 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #664909: 固定式應 ...

    Read More
    (333 Kb PDF, 2 pgs)

    Dec 15, 2022 ... 公告 2022 年 12 月 20 日 公告對象: 在下列學校註冊之兒童的家長或監護人 : California Crosspoint Academy 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英呎範圍 內的所 有居民及商戶。 公告單位: 灣區空氣質素管理局 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #664909: 固定式應 ...

  • 669835 Public Notice Chinese
    669835 Public Notice Chinese

    Jun 12, 2023 ... 公告 2023 年 06 月 14 日 公告對象: 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英呎範圍 內的所 有居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air Quality Management District (灣區 空氣質素管理局) 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #669835: 應 急備 用柴油 發電 機 ...

    Read More
    (436 Kb PDF, 2 pgs)

    Jun 12, 2023 ... 公告 2023 年 06 月 14 日 公告對象: 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英呎範圍 內的所 有居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air Quality Management District (灣區 空氣質素管理局) 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #669835: 應 急備 用柴油 發電 機 ...

  • 31986 Public Notice Chinese
    31986 Public Notice Chinese

    Jul 25, 2023 ... 公告 2023 年 7 月 27 日 公告對象: 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英呎範圍 內的所 有居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air Quality Management District (灣區空氣質素管理局) 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #31986: 七 (7) 台緊急備用 柴油發動機 (Seven ...

    Read More
    (363 Kb PDF, 2 pgs)

    Jul 25, 2023 ... 公告 2023 年 7 月 27 日 公告對象: 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英呎範圍 內的所 有居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air Quality Management District (灣區空氣質素管理局) 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #31986: 七 (7) 台緊急備用 柴油發動機 (Seven ...

  • 679129 Public Notice Chinese
    679129 Public Notice Chinese

    Aug 9, 2023 ... 公告 2023 年 8 月 11 日 公告對象: 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英呎範圍內的所 有居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air Quality Management District (灣區空氣質素管理局) 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #679129: 應 急 備 用 柴油 發 電 機 ...

    Read More
    (377 Kb PDF, 2 pgs)

    Aug 9, 2023 ... 公告 2023 年 8 月 11 日 公告對象: 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英呎範圍內的所 有居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air Quality Management District (灣區空氣質素管理局) 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #679129: 應 急 備 用 柴油 發 電 機 ...

  • 672456 Public Notice Chinese
    672456 Public Notice Chinese

    Jun 13, 2023 ... 公告 2023 年 6 月 15 日 公告對象: 在下列學校註冊之兒童的家長或監護人 : Hoover Elementary School 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英呎範圍 內的所 有居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air Quality Management District (灣區空氣質素管理局) 公告事由: ...

    Read More
    (337 Kb PDF, 2 pgs)

    Jun 13, 2023 ... 公告 2023 年 6 月 15 日 公告對象: 在下列學校註冊之兒童的家長或監護人 : Hoover Elementary School 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英呎範圍 內的所 有居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air Quality Management District (灣區空氣質素管理局) 公告事由: ...

  • 679453 Public Notice Chinese
    679453 Public Notice Chinese

    Oct 16, 2023 ... 公告 2023 年 10 月 17 日 公告對象: 在下列學校註冊之兒童的家長或監護人 : Bessie Carmichael Middle School 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英呎範圍 內的所 有居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air Quality Management District (灣區空氣質素管理局) ...

    Read More
    (339 Kb PDF, 2 pgs)

    Oct 16, 2023 ... 公告 2023 年 10 月 17 日 公告對象: 在下列學校註冊之兒童的家長或監護人 : Bessie Carmichael Middle School 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英呎範圍 內的所 有居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air Quality Management District (灣區空氣質素管理局) ...

  • 31157 Public Notice Chinese
    31157 Public Notice Chinese

    Nov 14, 2022 ... 公告 2022年 11月 15日 公告對象: 位於 離下 列提議中的新建或改建空氣污染源 1,000 英呎範圍 內的所 有居民及商 戶。 公告單位: 灣區空氣質素管理局 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #31157: Rodeo Renewed 項目 Phillips 66 Company - San Francisco Refinery 1380 ...

    Read More
    (926 Kb PDF, 2 pgs)

    Nov 14, 2022 ... 公告 2022年 11月 15日 公告對象: 位於 離下 列提議中的新建或改建空氣污染源 1,000 英呎範圍 內的所 有居民及商 戶。 公告單位: 灣區空氣質素管理局 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #31157: Rodeo Renewed 項目 Phillips 66 Company - San Francisco Refinery 1380 ...

  • 719446 Permit Evaluation
    719446 Permit Evaluation

    Sep 22, 2025 ... DRAFT ENGINEERING EVALUATION  Facility ID No. 203811 Sutter Health - Mission Bernal Care Complex 3501 Cesar Chavez Street, San Francisco, CA 94110 Application No. 719446   Background ...

    Read More
    (485 Kb PDF, 13 pgs)

    Sep 22, 2025 ... DRAFT ENGINEERING EVALUATION  Facility ID No. 203811 Sutter Health - Mission Bernal Care Complex 3501 Cesar Chavez Street, San Francisco, CA 94110 Application No. 719446   Background ...

  • April 3 2019 Meeting Summary
    April 3 2019 Meeting Summary

    West Oakland Environmental Indicators Project West Oakland Community Action Plan Steering Committee Meeting #9 Wednesday, April 3, 2019, 6:00 PM - 8:30 PM West Oakland Senior ...

    Read More
    (218 Kb PDF, 2 pgs)

    West Oakland Environmental Indicators Project West Oakland Community Action Plan Steering Committee Meeting #9 Wednesday, April 3, 2019, 6:00 PM - 8:30 PM West Oakland Senior ...

  • Jan 9 2019 Meeting Summary
    Jan 9 2019 Meeting Summary

    Feb 6, 2019 ... West Oakland Environmental Indicators Project West Oakland Community Action Plan Steering Committee Meeting #5 Wednesday, January 9, 2019, 6:00 - 8:30 pm West Oakland Senior ...

    Read More
    (233 Kb PDF, 2 pgs)

    Feb 6, 2019 ... West Oakland Environmental Indicators Project West Oakland Community Action Plan Steering Committee Meeting #5 Wednesday, January 9, 2019, 6:00 - 8:30 pm West Oakland Senior ...

  • Appendix B: Methodology for Derivation of Toxic Air Contaminant (TAC) Trigger Levels
    Appendix B: Methodology for Derivation of Toxic Air Contaminant (TAC) Trigger Levels

    Oct 26, 2016 ... Staff Report July 2016 Appendix B Methodology for Derivation of Toxic Air Contaminant (TAC) Trigger Levels ...

    Read More
    (193 Kb PDF, 11 pgs)

    Oct 26, 2016 ... Staff Report July 2016 Appendix B Methodology for Derivation of Toxic Air Contaminant (TAC) Trigger Levels ...

  • 702023 Permit Evaluation
    702023 Permit Evaluation

    Sep 2, 2025 ... DRAFT ENGINEERING EVALUATION  Facility ID No. 13923 Pacific Bell Corporation 555 Pine Street, San Francisco, CA 94108 Application No. 702023   Background  Pacific Bell Corporation is ...

    Read More
    (451 Kb PDF, 13 pgs)

    Sep 2, 2025 ... DRAFT ENGINEERING EVALUATION  Facility ID No. 13923 Pacific Bell Corporation 555 Pine Street, San Francisco, CA 94108 Application No. 702023   Background  Pacific Bell Corporation is ...

  • Meeting Slides
    Meeting Slides

    Mar 9, 2023 ... WOCAP Steering Committee November 2, 2022 West Oakland Community Action ...

    Read More
    (7 Mb PDF, 31 pgs)

    Mar 9, 2023 ... WOCAP Steering Committee November 2, 2022 West Oakland Community Action ...

  • Agreement
    Agreement

    SETILE.MENT AGREEMENT AND RELEASE BETWEEN 2 THE BAY AREA AIR QUALITY MANAGEMENT DISTRICT AND 3 CHEMTRADE WEST US LLC 4 1. The BAY AREA AIR QUALITY MANAGEMENT DISTRICT ("DISTRICT") and 5 6 ...

    Read More
    (614 Kb PDF, 4 pgs)

    SETILE.MENT AGREEMENT AND RELEASE BETWEEN 2 THE BAY AREA AIR QUALITY MANAGEMENT DISTRICT AND 3 CHEMTRADE WEST US LLC 4 1. The BAY AREA AIR QUALITY MANAGEMENT DISTRICT ("DISTRICT") and 5 6 ...

  • CAC 2024-2025 Work Plan
    CAC 2024-2025 Work Plan

    Calendar of Agenda Items (2024-2025 Work Plan) CAC Member Lead-Subject to Work Plan Agenda Items Potential Recommendations (or Information Only) Description of Community Benefit Change Develop ...

    Read More
    (51 Kb PDF, 2 pgs)

    Calendar of Agenda Items (2024-2025 Work Plan) CAC Member Lead-Subject to Work Plan Agenda Items Potential Recommendations (or Information Only) Description of Community Benefit Change Develop ...

  • 709283 Permit Evaluation
    709283 Permit Evaluation

    Mar 20, 2025 ... Montezuma Wetlands, LLC Facility #: 203615 Application #: 709283 DRAFT ENGINEERING EVALUATION Montezuma Wetlands, LLC 1285 Collinsville Road, Suisun City, CA 94585 Facility #: 203615 ...

    Read More
    (1 Mb PDF, 37 pgs)

    Mar 20, 2025 ... Montezuma Wetlands, LLC Facility #: 203615 Application #: 709283 DRAFT ENGINEERING EVALUATION Montezuma Wetlands, LLC 1285 Collinsville Road, Suisun City, CA 94585 Facility #: 203615 ...

  • HHHHHH Instructions
    HHHHHH Instructions

    May 2, 2008 ... What Is The Compliance Date? You can also contact your Regional EPA air toxics United States April 2008 office at the ...

    Read More
    (69 Kb PDF, 2 pgs)

    May 2, 2008 ... What Is The Compliance Date? You can also contact your Regional EPA air toxics United States April 2008 office at the ...

Spare the Air Status

Última actualización: 08/11/2016