Search

  • 477553 Public Notice Chinese
    477553 Public Notice Chinese

    May 3, 2019 ... 公告 2019 年 5 月 8 日 公告對象: 在下列學校註冊之兒童的家長或監護人 : Robert Louis Stevenson Elementary School 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英呎範圍 內的所有居民及商戶。 公告單位: 灣區空氣質素管理局 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #477553: 緊 急 ...

    Read More
    (337 Kb PDF, 2 pgs)

    May 3, 2019 ... 公告 2019 年 5 月 8 日 公告對象: 在下列學校註冊之兒童的家長或監護人 : Robert Louis Stevenson Elementary School 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英呎範圍 內的所有居民及商戶。 公告單位: 灣區空氣質素管理局 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #477553: 緊 急 ...

  • 473874 Public Notice Chinese
    473874 Public Notice Chinese

    Apr 29, 2019 ... 公告 2019 年 5 月 2 日 公告對象: 在下列學校註冊之兒童的家長或監護人 : Jean Parker Elementary School Gordon J. Lau Elementary School 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英呎範圍 內的所有居民及商戶。 公告單位: 灣區空氣質素管理局 公告事由: ...

    Read More
    (337 Kb PDF, 2 pgs)

    Apr 29, 2019 ... 公告 2019 年 5 月 2 日 公告對象: 在下列學校註冊之兒童的家長或監護人 : Jean Parker Elementary School Gordon J. Lau Elementary School 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英呎範圍 內的所有居民及商戶。 公告單位: 灣區空氣質素管理局 公告事由: ...

  • 464377 Public Notice Chinese
    464377 Public Notice Chinese

    Feb 21, 2018 ... 公告 2018 年 02 月 26 日 公告對象: 在下列學校註冊之兒童的家長或監護人 : Yu Ming Charter School Berkeley Maynard Academy 位於離下列提議中的新建或改建空氣污染源 1,000 英呎範圍 內的所有居民及商戶。 公告單位: 灣區空氣質素管理局 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #464377: ...

    Read More
    (246 Kb PDF, 2 pgs)

    Feb 21, 2018 ... 公告 2018 年 02 月 26 日 公告對象: 在下列學校註冊之兒童的家長或監護人 : Yu Ming Charter School Berkeley Maynard Academy 位於離下列提議中的新建或改建空氣污染源 1,000 英呎範圍 內的所有居民及商戶。 公告單位: 灣區空氣質素管理局 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #464377: ...

  • 29147 Public Notice Chinese
    29147 Public Notice Chinese

    Sep 20, 2018 ... 公告 2018 年 9 月 26 日 公告對象: 在下列學校註冊之兒童的家長或監護人 : Alamo Elementary School St. Monica School 位於離下列提議中的新建或改建空氣污染源 1,000 英呎範圍 內的所有居民及商戶。 公告單位: 灣區空氣質素管理局 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #29147: 咖啡烘培 器 ...

    Read More
    (437 Kb PDF, 2 pgs)

    Sep 20, 2018 ... 公告 2018 年 9 月 26 日 公告對象: 在下列學校註冊之兒童的家長或監護人 : Alamo Elementary School St. Monica School 位於離下列提議中的新建或改建空氣污染源 1,000 英呎範圍 內的所有居民及商戶。 公告單位: 灣區空氣質素管理局 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #29147: 咖啡烘培 器 ...

  • 29018 Public Notice Chinese
    29018 Public Notice Chinese

    Mar 7, 2018 ... 公告 2018 年 3 月 14 日 公告對象: 在下列學校註冊之兒童的家長或監護人 : Bayshore Elementary School Mt. Vernon Christian Academy 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英呎範圍 內的所有居民及商戶。 公告單位: 灣區空氣質素管理局 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 ...

    Read More
    (540 Kb PDF, 2 pgs)

    Mar 7, 2018 ... 公告 2018 年 3 月 14 日 公告對象: 在下列學校註冊之兒童的家長或監護人 : Bayshore Elementary School Mt. Vernon Christian Academy 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英呎範圍 內的所有居民及商戶。 公告單位: 灣區空氣質素管理局 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 ...

  • 30832 Public Notice Chinese
    30832 Public Notice Chinese

    Feb 9, 2022 ... 公告 2022 年 2 月 28 日 公告對象: 在下列學校註冊之兒童的家長或監護人 : The King’s Academy Rainbow Montessori C.D.C. San Miguel Elementary School 位於離下列提議中的新建或改建空氣污染源 1,000 英呎範圍 內的所有居民及商戶。 公告單位: 灣區空氣質素管理局 公告事由: ...

    Read More
    (261 Kb PDF, 2 pgs)

    Feb 9, 2022 ... 公告 2022 年 2 月 28 日 公告對象: 在下列學校註冊之兒童的家長或監護人 : The King’s Academy Rainbow Montessori C.D.C. San Miguel Elementary School 位於離下列提議中的新建或改建空氣污染源 1,000 英呎範圍 內的所有居民及商戶。 公告單位: 灣區空氣質素管理局 公告事由: ...

  • 27752 Public Notice Chinese
    27752 Public Notice Chinese

    Jul 26, 2016 ... 公告 2016 年 8 月 3 日 公告對象: 在下列學校註冊之兒童的家長或監護人 : Ronald C. Wornick Jewish Day School Bright Horizon Chinese School 位於離下列提議中的新建或改建空氣污染源 1,000 英呎範圍 內的所有居民及商戶。 公告單位: 灣區空氣質素管理局 公告事由: ...

    Read More
    (221 Kb PDF, 2 pgs)

    Jul 26, 2016 ... 公告 2016 年 8 月 3 日 公告對象: 在下列學校註冊之兒童的家長或監護人 : Ronald C. Wornick Jewish Day School Bright Horizon Chinese School 位於離下列提議中的新建或改建空氣污染源 1,000 英呎範圍 內的所有居民及商戶。 公告單位: 灣區空氣質素管理局 公告事由: ...

  • 629909 Public Notice Chinese
    629909 Public Notice Chinese

    Mar 10, 2021 ... 舊金山統一校區(San Francisco Unified School District)既不支持也不擔保本文件 中所述的組織或活動。此訊息的分發是社區服務的一部分。 公告 2021 年 3 月 12 日 公告對象: 在下列學校註冊之兒童的家長或監護人 : Raoul Wallenberg High School 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 ...

    Read More
    (389 Kb PDF, 2 pgs)

    Mar 10, 2021 ... 舊金山統一校區(San Francisco Unified School District)既不支持也不擔保本文件 中所述的組織或活動。此訊息的分發是社區服務的一部分。 公告 2021 年 3 月 12 日 公告對象: 在下列學校註冊之兒童的家長或監護人 : Raoul Wallenberg High School 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 ...

  • 29726 Public Notice Chinese
    29726 Public Notice Chinese

    Oct 4, 2019 ... 公告 2019 年 10 月 10 日 TO: 公告對象: 在下列學校註冊之兒童的家長或監護人 : San Francisco Community School Monroe Elementary School Stratford School – SF Middle School 位於離下列提議中的新建或改建空氣污染源 1,000 英呎範圍 內的所有居民及商戶。 ...

    Read More
    (355 Kb PDF, 2 pgs)

    Oct 4, 2019 ... 公告 2019 年 10 月 10 日 TO: 公告對象: 在下列學校註冊之兒童的家長或監護人 : San Francisco Community School Monroe Elementary School Stratford School – SF Middle School 位於離下列提議中的新建或改建空氣污染源 1,000 英呎範圍 內的所有居民及商戶。 ...

  • 29057 Public Notice Chinese
    29057 Public Notice Chinese

    Apr 17, 2018 ... 公告 2018 年 4 月 20 日 公告對象: 在下列學校註冊之兒童的家長或監護人 : Youth Chance High School 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英呎範圍 內的所有居民及商戶。 公告單位: 灣區空氣質素管理局 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #29057: 緊急備用 柴油防火泵 ...

    Read More
    (311 Kb PDF, 2 pgs)

    Apr 17, 2018 ... 公告 2018 年 4 月 20 日 公告對象: 在下列學校註冊之兒童的家長或監護人 : Youth Chance High School 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英呎範圍 內的所有居民及商戶。 公告單位: 灣區空氣質素管理局 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #29057: 緊急備用 柴油防火泵 ...

  • 29032 Public Notice Chinese
    29032 Public Notice Chinese

    Apr 4, 2018 ... 公告 2018 年 4 月 11 日 公告對象: 在下列學校註冊之兒童的家長或監護人 : Zion Lutheran School The Laurel School Star of the Sea School Frank McCoppin Elementary School 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英呎範圍 內的所有居民及商戶。 ...

    Read More
    (640 Kb PDF, 2 pgs)

    Apr 4, 2018 ... 公告 2018 年 4 月 11 日 公告對象: 在下列學校註冊之兒童的家長或監護人 : Zion Lutheran School The Laurel School Star of the Sea School Frank McCoppin Elementary School 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英呎範圍 內的所有居民及商戶。 ...

  • 20200205_Meeting Summary_SC Meeting pdf
    20200205_Meeting Summary_SC Meeting pdf

    Mar 30, 2020 ... !"# $ %&’!&" (# ) *+, - ( ./* 0 1 2 ...

    Read More
    (130 Kb PDF, 2 pgs)

    Mar 30, 2020 ... !"# $ %&’!&" (# ) *+, - ( ./* 0 1 2 ...

  • 27284 Public Notice Chinese
    27284 Public Notice Chinese

    Nov 23, 2015 ... 公告 2015 年 12 月 8 日 公告對象: 在下列學校註冊之兒童的家長或監護人: Sacred Heart Cathedral Preparatory (聖心主教預備高中) 位於離下列提議中的新建或改建空氣污染源 1,000 英呎範圍 內的所有居民及商戶。 公告單位: 灣區空氣質素管理局 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #27284: 三 (3) ...

    Read More
    (309 Kb PDF, 2 pgs)

    Nov 23, 2015 ... 公告 2015 年 12 月 8 日 公告對象: 在下列學校註冊之兒童的家長或監護人: Sacred Heart Cathedral Preparatory (聖心主教預備高中) 位於離下列提議中的新建或改建空氣污染源 1,000 英呎範圍 內的所有居民及商戶。 公告單位: 灣區空氣質素管理局 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #27284: 三 (3) ...

  • Committee Presentations
    Committee Presentations

    May 17, 2021 ... AGENDA: 3 Bay Area Regional Collaborative (BARC) Work Plan Update Allison Brooks BARC Executive Director May 19, ...

    Read More
    (897 Kb PDF, 70 pgs)

    May 17, 2021 ... AGENDA: 3 Bay Area Regional Collaborative (BARC) Work Plan Update Allison Brooks BARC Executive Director May 19, ...

  • 410501 Public Notice Chinese
    410501 Public Notice Chinese

    May 11, 2015 ... 公告告 20015 年 5 月 13 日 公告對象象: 在下列列學校註冊之兒童的家家長或監護人人: San LLorenzo Higgh School St. Joohn Catholiic School 位於離離下列提議中的新建或或改建空氣污污染源 1,0000 英呎範圍 內的所所有居民及商戶。 公告單位位: 灣區空空氣質素管理理局 公告事由由: ...

    Read More
    (174 Kb PDF, 2 pgs)

    May 11, 2015 ... 公告告 20015 年 5 月 13 日 公告對象象: 在下列列學校註冊之兒童的家家長或監護人人: San LLorenzo Higgh School St. Joohn Catholiic School 位於離離下列提議中的新建或或改建空氣污污染源 1,0000 英呎範圍 內的所所有居民及商戶。 公告單位位: 灣區空空氣質素管理理局 公告事由由: ...

  • BAAQMD Response to Comment
    BAAQMD Response to Comment

    Jul 31, 2012 ... July 17, 2012 June Guidotti’s comments on the proposed renewal Title V permit for Gilroy Energy Center, LLC at Wolfskill Energy Center and the BAAQMD Responses to those comments: Application ...

    Read More
    (152 Kb PDF, 2 pgs)

    Jul 31, 2012 ... July 17, 2012 June Guidotti’s comments on the proposed renewal Title V permit for Gilroy Energy Center, LLC at Wolfskill Energy Center and the BAAQMD Responses to those comments: Application ...

  • City of Oakland, Prologis Air Quality Operations Plan
    City of Oakland, Prologis Air Quality Operations Plan

    Apr 12, 2018 ... April 12, 2018 Patricia McGowan City of Oakland Environmental Coordinator BAY AREA City of Oakland Planning and Building Department 250 Frank H. Ogawa Plaza, Suite 3315 AIR Q!IALITY Oakland, CA ...

    Read More
    (126 Kb PDF, 3 pgs)

    Apr 12, 2018 ... April 12, 2018 Patricia McGowan City of Oakland Environmental Coordinator BAY AREA City of Oakland Planning and Building Department 250 Frank H. Ogawa Plaza, Suite 3315 AIR Q!IALITY Oakland, CA ...

  • Board Minutes
    Board Minutes

    Jun 17, 2021 ... Bay Area Air Quality Management District 375 Beale Street, Suite 600 San Francisco, CA 94105 (415) 749-5073 Board of Directors Special Meeting / Budget Hearing Wednesday, May 5, 2021 ...

    Read More
    (36 Kb PDF, 3 pgs)

    Jun 17, 2021 ... Bay Area Air Quality Management District 375 Beale Street, Suite 600 San Francisco, CA 94105 (415) 749-5073 Board of Directors Special Meeting / Budget Hearing Wednesday, May 5, 2021 ...

  • Board Presentations
    Board Presentations

    Jun 11, 2021 ... AGENDA: 25 Proposed Amendments to Regulation 3: Fees Board of Directors Meeting June 16, 2021 Fred Tanaka Manager ftanaka@baaqmd.gov Bay Area Air Quality Management ...

    Read More
    (1 Mb PDF, 67 pgs)

    Jun 11, 2021 ... AGENDA: 25 Proposed Amendments to Regulation 3: Fees Board of Directors Meeting June 16, 2021 Fred Tanaka Manager ftanaka@baaqmd.gov Bay Area Air Quality Management ...

  • 689807 Public Notice Vietnamese
    689807 Public Notice Vietnamese

    Aug 22, 2024 ... BỐ CÁO CÔNG CỘNG Ngày 28 tháng 8 năm 2024 KÍNH GỬI: Tất cả các cư gia và cơ sở thương mại nằm trong phạm vi 1.000 bộ (feet) cách nguồn gây ra ô nhiễm không khí mới hoặc được sửa đổi sau ...

    Read More
    (261 Kb PDF, 2 pgs)

    Aug 22, 2024 ... BỐ CÁO CÔNG CỘNG Ngày 28 tháng 8 năm 2024 KÍNH GỬI: Tất cả các cư gia và cơ sở thương mại nằm trong phạm vi 1.000 bộ (feet) cách nguồn gây ra ô nhiễm không khí mới hoặc được sửa đổi sau ...

Spare the Air Status