Search

  • Committee Agenda
    Committee Agenda

    Jun 10, 2015 ... BOARD OF DIRECTORS EXECUTIVE COMMITTEE MEETING COMMITTEE MEMBERS CAROLE GROOM – CHAIR ERIC MAR – VICE CHAIR TOM BATES JOHN GIOIA SCOTT HAGGERTY DAVID E. HUDSON NATE MILEY ...

    Read More
    (125 Kb PDF, 22 pgs)

    Jun 10, 2015 ... BOARD OF DIRECTORS EXECUTIVE COMMITTEE MEETING COMMITTEE MEMBERS CAROLE GROOM – CHAIR ERIC MAR – VICE CHAIR TOM BATES JOHN GIOIA SCOTT HAGGERTY DAVID E. HUDSON NATE MILEY ...

  • adv_053119_Trackout Advisory pdf
    adv_053119_Trackout Advisory pdf

    Jun 18, 2019 ... BAY AREA AIR~AUTY Compliance Advisory MANAGEMENT May 31, 2019 DISTRICT Prohibition of Trackout This Advisory is provided to inform you about Air District activities which may affect your ...

    Read More
    (2 Mb PDF, 5 pgs)

    Jun 18, 2019 ... BAY AREA AIR~AUTY Compliance Advisory MANAGEMENT May 31, 2019 DISTRICT Prohibition of Trackout This Advisory is provided to inform you about Air District activities which may affect your ...

  • 30617 Permit Evaluation
    30617 Permit Evaluation

    Oct 26, 2020 ... DRAFT ENGINEERING EVALUATION KAISER PERMANENTE SAN RAFAEL MEDICAL CENTER PLANT NO. 3947 APPLICATION NO: 30617 This document is an Engineering Evaluation Report for the issuance of an ...

    Read More
    (462 Kb PDF, 12 pgs)

    Oct 26, 2020 ... DRAFT ENGINEERING EVALUATION KAISER PERMANENTE SAN RAFAEL MEDICAL CENTER PLANT NO. 3947 APPLICATION NO: 30617 This document is an Engineering Evaluation Report for the issuance of an ...

  • 410501 Permit Evaluation
    410501 Permit Evaluation

    May 11, 2015 ... DRAFT ENGINEERING EVALUATION – AUTO BODY Facility ID No. 200085 Hernandez Auto Body 2 Lewelling Blvd. San Lorenzo, CA 94580-1628 Application No. 410501 Background Hernandez Auto Body ...

    Read More
    (54 Kb PDF, 6 pgs)

    May 11, 2015 ... DRAFT ENGINEERING EVALUATION – AUTO BODY Facility ID No. 200085 Hernandez Auto Body 2 Lewelling Blvd. San Lorenzo, CA 94580-1628 Application No. 410501 Background Hernandez Auto Body ...

  • 412820 Permit Evaluation
    412820 Permit Evaluation

    Oct 21, 2015 ... ENGINEERING EVALUATION – AUTO BODY Facility ID No. 200147 Quality Auto Body & Painting 3012 Spring St. Redwood City, 94063 Application No. 412820 Background Quality Auto Body & ...

    Read More
    (54 Kb PDF, 6 pgs)

    Oct 21, 2015 ... ENGINEERING EVALUATION – AUTO BODY Facility ID No. 200147 Quality Auto Body & Painting 3012 Spring St. Redwood City, 94063 Application No. 412820 Background Quality Auto Body & ...

  • 411511 Permit Evaluation
    411511 Permit Evaluation

    Jul 16, 2015 ... ENGINEERING EVALUATION – AUTO BODY Facility ID No. 200105 Auto Art and Body 25195 Huntwood Ave Hayward, CA 94544 Application No. 411551 Background Auto Art and Body is applying for an ...

    Read More
    (51 Kb PDF, 6 pgs)

    Jul 16, 2015 ... ENGINEERING EVALUATION – AUTO BODY Facility ID No. 200105 Auto Art and Body 25195 Huntwood Ave Hayward, CA 94544 Application No. 411551 Background Auto Art and Body is applying for an ...

  • Committee Presentations
    Committee Presentations

    Jun 6, 2025 ... AGENDA: 4 Mid-Year Review of the 2025-2026 Regulatory Agenda Stationary Source Committee June 11, 2025 Bradley Cole Manager Regulatory Development ...

    Read More
    (634 Kb PDF, 32 pgs)

    Jun 6, 2025 ... AGENDA: 4 Mid-Year Review of the 2025-2026 Regulatory Agenda Stationary Source Committee June 11, 2025 Bradley Cole Manager Regulatory Development ...

  • Committee Presentations
    Committee Presentations

    Jun 10, 2025 ... AGENDA: 4 Mid-Year Review of the 2025-2026 Regulatory Agenda Stationary Source Committee June 11, 2025 Bradley Cole Manager Regulatory Development ...

    Read More
    (636 Kb PDF, 32 pgs)

    Jun 10, 2025 ... AGENDA: 4 Mid-Year Review of the 2025-2026 Regulatory Agenda Stationary Source Committee June 11, 2025 Bradley Cole Manager Regulatory Development ...

  • Committee Agenda
    Committee Agenda

    Apr 5, 2018 ... BOARD OF DIRECTORS AD HOC REFINERY OVERSIGHT COMMITTEE COMMITTEE MEMBERS CINDY CHAVEZ - CHAIR NATE MILEY - VICE-CHAIR MARGARET ABE-KOGA PAULINE RUSSO CUTTER ...

    Read More
    (449 Kb PDF, 22 pgs)

    Apr 5, 2018 ... BOARD OF DIRECTORS AD HOC REFINERY OVERSIGHT COMMITTEE COMMITTEE MEMBERS CINDY CHAVEZ - CHAIR NATE MILEY - VICE-CHAIR MARGARET ABE-KOGA PAULINE RUSSO CUTTER ...

  • 700623 Public Notice Chinese
    700623 Public Notice Chinese

    Sep 3, 2025 ... 公告 2025 年9月10日 公告對象: 在下 列學校註冊之兒童的家長或監護人: Aspire Berkley Maynard Academy 位於 離下 列提議中的新建或改建空氣 污染源1,000 英尺(305 米)範圍 內 的所有居民及商 戶。 公告單位: Bay Area Air Quality Management District (灣區空氣質素管理局) ...

    Read More
    (1 Mb PDF, 2 pgs)

    Sep 3, 2025 ... 公告 2025 年9月10日 公告對象: 在下 列學校註冊之兒童的家長或監護人: Aspire Berkley Maynard Academy 位於 離下 列提議中的新建或改建空氣 污染源1,000 英尺(305 米)範圍 內 的所有居民及商 戶。 公告單位: Bay Area Air Quality Management District (灣區空氣質素管理局) ...

  • 30753 Public Notice Chinese
    30753 Public Notice Chinese

    Aug 23, 2021 ... 公告 2021 年 8 月 25 日 公告對象: 公告對象: 在下列學校註冊之兒童的家長或監護人: Sacred Heart Cathedral Preparatory Tenderloin Community Elementary School 位於離下列提議中的新建或改建空氣污染源 1,000 英呎範圍 內的所有居民及商戶。 公告單位: 灣區空氣質素管理局 ...

    Read More
    (442 Kb PDF, 2 pgs)

    Aug 23, 2021 ... 公告 2021 年 8 月 25 日 公告對象: 公告對象: 在下列學校註冊之兒童的家長或監護人: Sacred Heart Cathedral Preparatory Tenderloin Community Elementary School 位於離下列提議中的新建或改建空氣污染源 1,000 英呎範圍 內的所有居民及商戶。 公告單位: 灣區空氣質素管理局 ...

  • 696718 Public Notice Chinese
    696718 Public Notice Chinese

    Nov 8, 2024 ... 公告 2024 年 11 月 26 日 公告對象: 在下列學校註冊之兒童的家長或監護人 : Robert Louis Stevenson Elementary School 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英尺(305 米)範 圍內的所有居民及商戶 。 公告單位: Bay Area Air Quality Management District ...

    Read More
    (347 Kb PDF, 2 pgs)

    Nov 8, 2024 ... 公告 2024 年 11 月 26 日 公告對象: 在下列學校註冊之兒童的家長或監護人 : Robert Louis Stevenson Elementary School 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英尺(305 米)範 圍內的所有居民及商戶 。 公告單位: Bay Area Air Quality Management District ...

  • 682990 Public Notice Chinese
    682990 Public Notice Chinese

    Aug 28, 2023 ... 公告 2023 年 8 月 30 日 公告對象: 位於 離下 列提議中的新建或改建空氣污染源 1,000 英呎範圍 內的所有 居民及商 戶。 公告單位: Bay Area Air Quality Management District (灣區空氣質素管理局) 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #682990: 固定式應急柴油機 —— 發電機組 ...

    Read More
    (979 Kb PDF, 2 pgs)

    Aug 28, 2023 ... 公告 2023 年 8 月 30 日 公告對象: 位於 離下 列提議中的新建或改建空氣污染源 1,000 英呎範圍 內的所有 居民及商 戶。 公告單位: Bay Area Air Quality Management District (灣區空氣質素管理局) 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #682990: 固定式應急柴油機 —— 發電機組 ...

  • 723222 Public Notice Chinese
    723222 Public Notice Chinese

    Jul 18, 2025 ... 公告 2025 年7月23日 公告對象: 位於 離下 列提議中的新建或改建空氣污染源1,000 英尺(305 米)範 圍 內的所有居民及商 戶。 公告單位: Bay Area Air Quality Management District (灣區空氣質素管理局) 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #723222: 1 台新的柴油驅動應急消防泵浦引擎 (1 ...

    Read More
    (1 Mb PDF, 2 pgs)

    Jul 18, 2025 ... 公告 2025 年7月23日 公告對象: 位於 離下 列提議中的新建或改建空氣污染源1,000 英尺(305 米)範 圍 內的所有居民及商 戶。 公告單位: Bay Area Air Quality Management District (灣區空氣質素管理局) 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #723222: 1 台新的柴油驅動應急消防泵浦引擎 (1 ...

  • 640580 Public Notice Chinese
    640580 Public Notice Chinese

    Jun 23, 2021 ... 公告 2021 年 6 月 25 日 公告對象: 公告對象: 在下列學校註冊之兒童的家長或監護人: Coastline Christian School 位於離下列提議中的新建或改建空氣污染源 1,000 英呎範圍 內的所有居民及商戶。 公告單位: 灣區空氣質素管理局 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #640580: 緊急備用 柴油消防泵 ...

    Read More
    (518 Kb PDF, 2 pgs)

    Jun 23, 2021 ... 公告 2021 年 6 月 25 日 公告對象: 公告對象: 在下列學校註冊之兒童的家長或監護人: Coastline Christian School 位於離下列提議中的新建或改建空氣污染源 1,000 英呎範圍 內的所有居民及商戶。 公告單位: 灣區空氣質素管理局 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #640580: 緊急備用 柴油消防泵 ...

  • 26376 Public Notice Chinese
    26376 Public Notice Chinese

    Dec 19, 2014 ... 公告 2015 年 1 月 8 日 公告對象: 在下列學校註冊之兒童的家長或監護人: Marina Middle School 位於離下列提議中的新建或改建空氣污染源 1,000 英呎範 圍內的所有居民及商戶。 公告單位: 灣區空氣質素管理局 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #26376: 一台緊急備用天然氣引擎發電機組 (Stationary ...

    Read More
    (216 Kb PDF, 2 pgs)

    Dec 19, 2014 ... 公告 2015 年 1 月 8 日 公告對象: 在下列學校註冊之兒童的家長或監護人: Marina Middle School 位於離下列提議中的新建或改建空氣污染源 1,000 英呎範 圍內的所有居民及商戶。 公告單位: 灣區空氣質素管理局 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #26376: 一台緊急備用天然氣引擎發電機組 (Stationary ...

  • 696353 Public Notice Chinese
    696353 Public Notice Chinese

    Nov 14, 2024 ... 公告 2024 年 11 月 22 日 公告對象: 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英尺(305 米) 範 圍內的所有居民及商 戶。 公告單位: Bay Area Air Quality Management District ( 灣區空氣質素管理局) 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #696353: 應急備用 柴油發電機 ...

    Read More
    (335 Kb PDF, 2 pgs)

    Nov 14, 2024 ... 公告 2024 年 11 月 22 日 公告對象: 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英尺(305 米) 範 圍內的所有居民及商 戶。 公告單位: Bay Area Air Quality Management District ( 灣區空氣質素管理局) 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #696353: 應急備用 柴油發電機 ...

  • 32152 Public Notice Chinese
    32152 Public Notice Chinese

    Jul 24, 2025 ... 公告 2025 年7月30日 公告對象: 位於 離下 列提議中的新建或改建空氣 污染源1,000 英 尺 (305 米)範 圍 內的所有居民及商 戶。 公告單位: Bay Area Air Quality Management District (灣區空氣質素管理局) 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #32152: S-5 天然氣 動 物火 化爐 膛 — ...

    Read More
    (909 Kb PDF, 2 pgs)

    Jul 24, 2025 ... 公告 2025 年7月30日 公告對象: 位於 離下 列提議中的新建或改建空氣 污染源1,000 英 尺 (305 米)範 圍 內的所有居民及商 戶。 公告單位: Bay Area Air Quality Management District (灣區空氣質素管理局) 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #32152: S-5 天然氣 動 物火 化爐 膛 — ...

  • 31700 Public Notice Chinese
    31700 Public Notice Chinese

    Sep 4, 2025 ... 公告 2025 年9月12日 公告對象: 位於離下列提議中的新建或改建空氣污染源 5,000 英尺(1,524 米)範圍內 的所有居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air District (灣區空氣局) 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #31700: 綠色廢棄物制氫工廠 (Green waste to hydrogen production ...

    Read More
    (1 Mb PDF, 2 pgs)

    Sep 4, 2025 ... 公告 2025 年9月12日 公告對象: 位於離下列提議中的新建或改建空氣污染源 5,000 英尺(1,524 米)範圍內 的所有居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air District (灣區空氣局) 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #31700: 綠色廢棄物制氫工廠 (Green waste to hydrogen production ...

  • 719487 Public Notice Chinese
    719487 Public Notice Chinese

    Sep 2, 2025 ... 公告 2025 年9月9日 公告對象: 位於離下列提議中的新建或改建空氣污染源1,000 英尺(305 米)範圍內的 所有居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air District (灣區空氣管理局) 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #719487: 兩 (2) 台應急備用柴油引擎 (Two Emergency Backup Diesel ...

    Read More
    (1 Mb PDF, 2 pgs)

    Sep 2, 2025 ... 公告 2025 年9月9日 公告對象: 位於離下列提議中的新建或改建空氣污染源1,000 英尺(305 米)範圍內的 所有居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air District (灣區空氣管理局) 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #719487: 兩 (2) 台應急備用柴油引擎 (Two Emergency Backup Diesel ...

Spare the Air Status