Hanapin

  • 669468 Public Notice Vietnamese
    669468 Public Notice Vietnamese

    Mar 13, 2023 ... BỐ CÁO CÔNG CỘNG Ngày 21 tháng 3 năm 2023 KÍNH GỬI: Tất cả các cư gia và cơ sở thương mại nằm trong phạm vi 1.000 bộ (feet) cách nguồn gây ra ô nhiễm không khí mới hoặc được sửa đổi sau ...

    Read More
    (258 Kb PDF, 2 pgs)

    Mar 13, 2023 ... BỐ CÁO CÔNG CỘNG Ngày 21 tháng 3 năm 2023 KÍNH GỬI: Tất cả các cư gia và cơ sở thương mại nằm trong phạm vi 1.000 bộ (feet) cách nguồn gây ra ô nhiễm không khí mới hoặc được sửa đổi sau ...

  • 724878 Public Notice Vietnamese
    724878 Public Notice Vietnamese

    Jan 26, 2026 ... BỐ CÁO CÔNG CỘNG Ngày 9 tháng 2 năm 2026 KÍNH GỬI: Tất cả các cư gia và cơ sở thương mại nằm trong phạm vi 1.000 bộ (305 m) cách nguồn gây ra ô nhiễm không khí mới hoặc được sửa đổi sau ...

    Read More
    (304 Kb PDF, 2 pgs)

    Jan 26, 2026 ... BỐ CÁO CÔNG CỘNG Ngày 9 tháng 2 năm 2026 KÍNH GỬI: Tất cả các cư gia và cơ sở thương mại nằm trong phạm vi 1.000 bộ (305 m) cách nguồn gây ra ô nhiễm không khí mới hoặc được sửa đổi sau ...

  • Board Agenda
    Board Agenda

    Jan 14, 2022 ... BOARD OF DIRECTORS / RETREAT MEETING January 19, 2022 THIS MEETING WILL BE CONDUCTED UNDER PROCEDURES AUTHORIZED BY ASSEMBLY BILL 361 • THE PUBLIC MAY OBSERVE THIS MEETING THROUGH THE WEBCAST ...

    Read More
    (8 Mb PDF, 142 pgs)

    Jan 14, 2022 ... BOARD OF DIRECTORS / RETREAT MEETING January 19, 2022 THIS MEETING WILL BE CONDUCTED UNDER PROCEDURES AUTHORIZED BY ASSEMBLY BILL 361 • THE PUBLIC MAY OBSERVE THIS MEETING THROUGH THE WEBCAST ...

  • 689807 Public Notice Vietnamese
    689807 Public Notice Vietnamese

    Aug 22, 2024 ... BỐ CÁO CÔNG CỘNG Ngày 28 tháng 8 năm 2024 KÍNH GỬI: Tất cả các cư gia và cơ sở thương mại nằm trong phạm vi 1.000 bộ (feet) cách nguồn gây ra ô nhiễm không khí mới hoặc được sửa đổi sau ...

    Read More
    (261 Kb PDF, 2 pgs)

    Aug 22, 2024 ... BỐ CÁO CÔNG CỘNG Ngày 28 tháng 8 năm 2024 KÍNH GỬI: Tất cả các cư gia và cơ sở thương mại nằm trong phạm vi 1.000 bộ (feet) cách nguồn gây ra ô nhiễm không khí mới hoặc được sửa đổi sau ...

  • 672028 Public Notice Vietnamese
    672028 Public Notice Vietnamese

    Mar 14, 2023 ... BỐ CÁO CÔNG CỘNG Ngày 21 tháng 3 năm 2023 KÍNH GỬI: Tất cả các cư gia và cơ sở thương mại nằm trong phạm vi 1.000 bộ (feet) cách nguồn gây ra ô nhiễm không khí mới hoặc được sửa đổi sau ...

    Read More
    (264 Kb PDF, 2 pgs)

    Mar 14, 2023 ... BỐ CÁO CÔNG CỘNG Ngày 21 tháng 3 năm 2023 KÍNH GỬI: Tất cả các cư gia và cơ sở thương mại nằm trong phạm vi 1.000 bộ (feet) cách nguồn gây ra ô nhiễm không khí mới hoặc được sửa đổi sau ...

  • Semi-Annual Monitoring Report 2019 B
    Semi-Annual Monitoring Report 2019 B

    Mar 16, 2020 ... Silicon Valley Power î SILICON 2020 MAR 16 AM IO: 54 City of Santa Clara nt··,, ,, ; :- ' '· I;) C. i , •. , , -.· y VALLEY 1500 Warburton Ave. Ut 11 it,\·4, ~ /1, 1\ î _J/\LI I Mr.; 1:, G :: ...

    Read More
    (11 Mb PDF, 26 pgs)

    Mar 16, 2020 ... Silicon Valley Power î SILICON 2020 MAR 16 AM IO: 54 City of Santa Clara nt··,, ,, ; :- ' '· I;) C. i , •. , , -.· y VALLEY 1500 Warburton Ave. Ut 11 it,\·4, ~ /1, 1\ î _J/\LI I Mr.; 1:, G :: ...

  • Semi-Annual Monitoring Report 2021 B
    Semi-Annual Monitoring Report 2021 B

    Apr 21, 2022 ... OAKLAND POWER COMPANY LLC PO BOX 690 MOSS LANDING, CA 95039 831-633-6700 CERTIFIED MAIL# 7020 3160 0000 6956 4517 RETURN RECEIPT. March 30, 2022 •' .·, -.J ....... Director of Compliance ...

    Read More
    (4 Mb PDF, 8 pgs)

    Apr 21, 2022 ... OAKLAND POWER COMPANY LLC PO BOX 690 MOSS LANDING, CA 95039 831-633-6700 CERTIFIED MAIL# 7020 3160 0000 6956 4517 RETURN RECEIPT. March 30, 2022 •' .·, -.J ....... Director of Compliance ...

  • July 10 2019 Meeting Summary
    July 10 2019 Meeting Summary

    West Oakland Community Action Plan Steering Committee Meeting #13 Wednesday, July 10, 2019, 5:30 pm — 8:30 pm West Oakland Senior Center 1724 Adeline Street Oakland, CA 94607 Meeting ...

    Read More
    (195 Kb PDF, 2 pgs)

    West Oakland Community Action Plan Steering Committee Meeting #13 Wednesday, July 10, 2019, 5:30 pm — 8:30 pm West Oakland Senior Center 1724 Adeline Street Oakland, CA 94607 Meeting ...

  • Semi-Annual Monitoring Report 2019 A
    Semi-Annual Monitoring Report 2019 A

    Feb 25, 2020 ... 2020 JAN 2 7 PM I: I 8 e A E January 1 7, 2020 Director of Compliance and Enforcement Attention: Title V Reports Bay Area Air Quality Management District 375 Beale Street #600 San Francisco, ...

    Read More
    (1 Mb PDF, 6 pgs)

    Feb 25, 2020 ... 2020 JAN 2 7 PM I: I 8 e A E January 1 7, 2020 Director of Compliance and Enforcement Attention: Title V Reports Bay Area Air Quality Management District 375 Beale Street #600 San Francisco, ...

  • June 26 2019 Meeting Summary
    June 26 2019 Meeting Summary

    West Oakland Environmental Indicators Project West Oakland Community Action Plan Steering Committee Meeting #12 Wednesday, June 26, 2019, 5:30 pm — 8:30 pm Alameda County Public Health ...

    Read More
    (234 Kb PDF, 2 pgs)

    West Oakland Environmental Indicators Project West Oakland Community Action Plan Steering Committee Meeting #12 Wednesday, June 26, 2019, 5:30 pm — 8:30 pm Alameda County Public Health ...

  • Semi-Annual Monitoring Report 2021 A
    Semi-Annual Monitoring Report 2021 A

    Feb 8, 2022 ... OAKLAND POWER COMPANY LLC Zû22 JMJ 3 I AH li: 3 I PO BOX 690 MOSS LANDING CA 95039 831-633-6700 CERTIFIED MAIL# 7019 2970 0000 5051 9942 RETURN RECEIPT January 26, 2022 Director of Compliance ...

    Read More
    (4 Mb PDF, 9 pgs)

    Feb 8, 2022 ... OAKLAND POWER COMPANY LLC Zû22 JMJ 3 I AH li: 3 I PO BOX 690 MOSS LANDING CA 95039 831-633-6700 CERTIFIED MAIL# 7019 2970 0000 5051 9942 RETURN RECEIPT January 26, 2022 Director of Compliance ...

  • Committee Agenda
    Committee Agenda

    Okt 11, 2024 ... ...

    Read More
    (3 Mb PDF, 47 pgs)

    Okt 11, 2024 ... ...

  • Response to Comments
    Response to Comments

    Jan 2, 2013 ... Response to Comments Cardinal Cogen A1629, Application 21629 Response to Comments from Ron Dahlin, General Manager, Cardinal Cogen, Inc., regarding the Draft Renewal of the Major Facility Permit ...

    Read More
    (690 Kb PDF, 11 pgs)

    Jan 2, 2013 ... Response to Comments Cardinal Cogen A1629, Application 21629 Response to Comments from Ron Dahlin, General Manager, Cardinal Cogen, Inc., regarding the Draft Renewal of the Major Facility Permit ...

  • Committee Agenda
    Committee Agenda

    Abr 11, 2025 ... BOARD OF DIRECTORS FINANCE AND ADMINISTRATION COMMITTEE April 16, 2025 COMMITTEE MEMBERS LYNDA HOPKINS – CHAIR TYRONE JUE –VICE CHAIR NOELIA CORZO JUAN GONZÁLEZ III DAVID HAUBERT SERGIO ...

    Read More
    (10 Mb PDF, 262 pgs)

    Abr 11, 2025 ... BOARD OF DIRECTORS FINANCE AND ADMINISTRATION COMMITTEE April 16, 2025 COMMITTEE MEMBERS LYNDA HOPKINS – CHAIR TYRONE JUE –VICE CHAIR NOELIA CORZO JUAN GONZÁLEZ III DAVID HAUBERT SERGIO ...

  • 26419 Public Notice Chinese
    26419 Public Notice Chinese

    Oct 15, 2014 ... 公告告 20014 年 10 月 17 日 公告對象象: 在下列列學校註冊之兒童的家家長或監護人人: Chinese Educatiion Center EElementaryy School(華華人教育中心心小學) Stt. Mary’s Scchool 位於離離下列提議中的新建或或改建空氣污污染源 1,0000 英呎範圍 內的所所有居民及商戶。 公告單位位: ...

    Read More
    (205 Kb PDF, 2 pgs)

    Oct 15, 2014 ... 公告告 20014 年 10 月 17 日 公告對象象: 在下列列學校註冊之兒童的家家長或監護人人: Chinese Educatiion Center EElementaryy School(華華人教育中心心小學) Stt. Mary’s Scchool 位於離離下列提議中的新建或或改建空氣污污染源 1,0000 英呎範圍 內的所所有居民及商戶。 公告單位位: ...

  • Semi-Annual Monitoring Report 2023 A
    Semi-Annual Monitoring Report 2023 A

    Aug 3, 2023 ... Martinez Tennlnal Company LLC ~artinez 1801 Marina Vista Avenue ~ ~::~inal Company LLC Martinez, CA 94553 www.pbfenergy.com July 31, 2023 1/ / VIA UPS Mr. Jeffrey Gove Compliance and ...

    Read More
    (2 Mb PDF, 4 pgs)

    Aug 3, 2023 ... Martinez Tennlnal Company LLC ~artinez 1801 Marina Vista Avenue ~ ~::~inal Company LLC Martinez, CA 94553 www.pbfenergy.com July 31, 2023 1/ / VIA UPS Mr. Jeffrey Gove Compliance and ...

  • Committee Agenda
    Committee Agenda

    Oct 28, 2022 ... BOARD OF DIRECTORS ADMINISTRATION COMMITTEE COMMITTEE MEMBERS JOHN J. BAUTERS – CHAIR DAVINA HURT - VICE CHAIR MARGARET ABE-KOGA JOHN GIOIA CAROLE GROOM DAVID HUDSON TYRONE JUE KAREN ...

    Read More
    (472 Kb PDF, 37 pgs)

    Oct 28, 2022 ... BOARD OF DIRECTORS ADMINISTRATION COMMITTEE COMMITTEE MEMBERS JOHN J. BAUTERS – CHAIR DAVINA HURT - VICE CHAIR MARGARET ABE-KOGA JOHN GIOIA CAROLE GROOM DAVID HUDSON TYRONE JUE KAREN ...

  • Comments from Shell Section III
    Comments from Shell Section III

    Jan 14, 2005 ... Section III NSPS Subpart J - Fuel Gas Combustion Devices Process Vents Alternative Monitoring NSPS Subpart J requires that H S in fuel gas be limited to 163 ppm if the fuel gas is combusted ...

    Read More
    (32 Kb PDF, 4 pgs)

    Jan 14, 2005 ... Section III NSPS Subpart J - Fuel Gas Combustion Devices Process Vents Alternative Monitoring NSPS Subpart J requires that H S in fuel gas be limited to 163 ppm if the fuel gas is combusted ...

  • Toxics Annual Report Appendix B
    Toxics Annual Report Appendix B

    Sep 18, 2024 ... Toxic Air Contaminant Control Program Annual Report September 2024 APPENDIX B – FACILITY RANKINGS AND REVIEW PHASES This appendix provides the prioritization scores and facility rank (high, ...

    Read More
    (4 Mb PDF, 162 pgs)

    Sep 18, 2024 ... Toxic Air Contaminant Control Program Annual Report September 2024 APPENDIX B – FACILITY RANKINGS AND REVIEW PHASES This appendix provides the prioritization scores and facility rank (high, ...

  • Semi-Annual Monitoring Report 2022 B
    Semi-Annual Monitoring Report 2022 B

    Aug 3, 2023 ... 3485 Pacheco Boulevard ~artinez Martinez, CA 94553 \ ~:~~ing Company July 31, 2023 CERTIFIED MAIL - RETURN RECEIPT REQUESTED Mr. Jeffrey Gove Compliance and Enforcement ( ,L ... ; " Bay ...

    Read More
    (10 Mb PDF, 18 pgs)

    Aug 3, 2023 ... 3485 Pacheco Boulevard ~artinez Martinez, CA 94553 \ ~:~~ing Company July 31, 2023 CERTIFIED MAIL - RETURN RECEIPT REQUESTED Mr. Jeffrey Gove Compliance and Enforcement ( ,L ... ; " Bay ...

Spare the Air Status

Huling Isinapanahon: 11/8/2016