Hanapin

  • 669800 Public Notice Chinese
    669800 Public Notice Chinese

    Sep 13, 2023 ... 公告 2023 年 9 月 20 日 公告對象: 在下列學校註冊之兒童的家長或監護人 : Marshall Elementary School San Francisco Friends School Millennium School Children's Day School 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英呎範圍 ...

    Read More
    (323 Kb PDF, 2 pgs)

    Sep 13, 2023 ... 公告 2023 年 9 月 20 日 公告對象: 在下列學校註冊之兒童的家長或監護人 : Marshall Elementary School San Francisco Friends School Millennium School Children's Day School 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英呎範圍 ...

  • 676820 Public Notice Chinese
    676820 Public Notice Chinese

    Aug 15, 2023 ... 公告 2023 年 08 月 17 日 公告對象: 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英呎範圍內的所 有居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air Quality Management District (灣區空氣質素管理局) 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #676820: 應急 備用柴油發 電機 (Emergency ...

    Read More
    (326 Kb PDF, 2 pgs)

    Aug 15, 2023 ... 公告 2023 年 08 月 17 日 公告對象: 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英呎範圍內的所 有居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air Quality Management District (灣區空氣質素管理局) 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #676820: 應急 備用柴油發 電機 (Emergency ...

  • 672234 Public Notice Chinese
    672234 Public Notice Chinese

    Jul 6, 2023 ... 公告 2023 年 7 月 7 日 公告對象: 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英呎範圍內的所 有居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air Quality Management District (灣區空氣質素管理局) 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #672234: 台 應 急 備 用柴 油 發 電 機組 ...

    Read More
    (333 Kb PDF, 2 pgs)

    Jul 6, 2023 ... 公告 2023 年 7 月 7 日 公告對象: 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英呎範圍內的所 有居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air Quality Management District (灣區空氣質素管理局) 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #672234: 台 應 急 備 用柴 油 發 電 機組 ...

  • 31232 Public Notice Chinese
    31232 Public Notice Chinese

    Mar 21, 2023 ... 公告 2023 年 3 月 30 日 公告對象: 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英呎範圍內的所 有居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air Quality Management District (灣區空氣質素管理局) 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #31232: 應急 備用柴油發 電機 (Emergency ...

    Read More
    (443 Kb PDF, 2 pgs)

    Mar 21, 2023 ... 公告 2023 年 3 月 30 日 公告對象: 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英呎範圍內的所 有居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air Quality Management District (灣區空氣質素管理局) 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #31232: 應急 備用柴油發 電機 (Emergency ...

  • 672456 Public Notice Chinese
    672456 Public Notice Chinese

    Hun 13, 2023 ... 公告 2023 年 6 月 15 日 公告對象: 在下列學校註冊之兒童的家長或監護人 : Hoover Elementary School 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英呎範圍 內的所 有居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air Quality Management District (灣區空氣質素管理局) 公告事由: ...

    Read More
    (337 Kb PDF, 2 pgs)

    Hun 13, 2023 ... 公告 2023 年 6 月 15 日 公告對象: 在下列學校註冊之兒童的家長或監護人 : Hoover Elementary School 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英呎範圍 內的所 有居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air Quality Management District (灣區空氣質素管理局) 公告事由: ...

  • 669835 Public Notice Chinese
    669835 Public Notice Chinese

    Hun 12, 2023 ... 公告 2023 年 06 月 14 日 公告對象: 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英呎範圍 內的所 有居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air Quality Management District (灣區 空氣質素管理局) 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #669835: 應 急備 用柴油 發電 機 ...

    Read More
    (436 Kb PDF, 2 pgs)

    Hun 12, 2023 ... 公告 2023 年 06 月 14 日 公告對象: 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英呎範圍 內的所 有居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air Quality Management District (灣區 空氣質素管理局) 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #669835: 應 急備 用柴油 發電 機 ...

  • 676886 Public Notice Chinese
    676886 Public Notice Chinese

    Set 13, 2023 ... 公告 2023 年 09 月 22 日 公告對象: 在下列學校註冊之兒童的家長或監護人 : Yu Ming Charter School Upper School (育明中英雙語學院) 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英呎範圍 內的所 有居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air Quality Management ...

    Read More
    (340 Kb PDF, 2 pgs)

    Set 13, 2023 ... 公告 2023 年 09 月 22 日 公告對象: 在下列學校註冊之兒童的家長或監護人 : Yu Ming Charter School Upper School (育明中英雙語學院) 位於離下列提議中的新建或改建空氣 污染源 1,000 英呎範圍 內的所 有居民及商戶。 公告單位: Bay Area Air Quality Management ...

  • 31157 Public Notice Chinese
    31157 Public Notice Chinese

    Nob 14, 2022 ... 公告 2022年 11月 15日 公告對象: 位於 離下 列提議中的新建或改建空氣污染源 1,000 英呎範圍 內的所 有居民及商 戶。 公告單位: 灣區空氣質素管理局 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #31157: Rodeo Renewed 項目 Phillips 66 Company - San Francisco Refinery 1380 ...

    Read More
    (926 Kb PDF, 2 pgs)

    Nob 14, 2022 ... 公告 2022年 11月 15日 公告對象: 位於 離下 列提議中的新建或改建空氣污染源 1,000 英呎範圍 內的所 有居民及商 戶。 公告單位: 灣區空氣質素管理局 公告事由: 下列空氣污染源的許可證申請 #31157: Rodeo Renewed 項目 Phillips 66 Company - San Francisco Refinery 1380 ...

  • Meeting Notes
    Meeting Notes

    A G E N D A E a s t Oa k l a nd AB 6 1 7 C o mmu ni t y St e e ri ng C o mmi t t e e (C SC ) Me e t i ng # 1 0 Date & Time: Thursday, July 13th, 2023, 6:00 pm to 8:00 pm PDT Virtual Facilitator: ...

    Read More
    (892 Kb PDF, 8 pgs)

    A G E N D A E a s t Oa k l a nd AB 6 1 7 C o mmu ni t y St e e ri ng C o mmi t t e e (C SC ) Me e t i ng # 1 0 Date & Time: Thursday, July 13th, 2023, 6:00 pm to 8:00 pm PDT Virtual Facilitator: ...

  • Jan 9 2019 Meeting Summary
    Jan 9 2019 Meeting Summary

    Peb 6, 2019 ... West Oakland Environmental Indicators Project West Oakland Community Action Plan Steering Committee Meeting #5 Wednesday, January 9, 2019, 6:00 - 8:30 pm West Oakland Senior ...

    Read More
    (233 Kb PDF, 2 pgs)

    Peb 6, 2019 ... West Oakland Environmental Indicators Project West Oakland Community Action Plan Steering Committee Meeting #5 Wednesday, January 9, 2019, 6:00 - 8:30 pm West Oakland Senior ...

  • April 3 2019 Meeting Summary
    April 3 2019 Meeting Summary

    West Oakland Environmental Indicators Project West Oakland Community Action Plan Steering Committee Meeting #9 Wednesday, April 3, 2019, 6:00 PM - 8:30 PM West Oakland Senior ...

    Read More
    (218 Kb PDF, 2 pgs)

    West Oakland Environmental Indicators Project West Oakland Community Action Plan Steering Committee Meeting #9 Wednesday, April 3, 2019, 6:00 PM - 8:30 PM West Oakland Senior ...

  • Appendix B: Methodology for Derivation of Toxic Air Contaminant (TAC) Trigger Levels
    Appendix B: Methodology for Derivation of Toxic Air Contaminant (TAC) Trigger Levels

    Okt 26, 2016 ... Staff Report July 2016 Appendix B Methodology for Derivation of Toxic Air Contaminant (TAC) Trigger Levels ...

    Read More
    (193 Kb PDF, 11 pgs)

    Okt 26, 2016 ... Staff Report July 2016 Appendix B Methodology for Derivation of Toxic Air Contaminant (TAC) Trigger Levels ...

  • March 11 2019 Meeting Summary
    March 11 2019 Meeting Summary

    West Oakland Environmental Indicators Project West Oakland Community Action Plan Steering Committee Meeting #8 Monday, March 11, 2019, 6:00 PM - 9:00 PM Alameda County Public ...

    Read More
    (242 Kb PDF, 3 pgs)

    West Oakland Environmental Indicators Project West Oakland Community Action Plan Steering Committee Meeting #8 Monday, March 11, 2019, 6:00 PM - 9:00 PM Alameda County Public ...

  • Minutes
    Minutes

    Ago 28, 2023 ... A G E N D A E a s t Oa k l a nd AB 6 1 7 C o mmu ni t y St e e ri ng C o mmi t t e e (C SC ) Me e t i ng # 1 1 D a t e & Ti me : T hur s da y, A ug us t 1 0 t h, 2 0 2 3 , 6 :0 0 pm t o 8 :0 0 pm P ...

    Read More
    (157 Kb PDF, 9 pgs)

    Ago 28, 2023 ... A G E N D A E a s t Oa k l a nd AB 6 1 7 C o mmu ni t y St e e ri ng C o mmi t t e e (C SC ) Me e t i ng # 1 1 D a t e & Ti me : T hur s da y, A ug us t 1 0 t h, 2 0 2 3 , 6 :0 0 pm t o 8 :0 0 pm P ...

  • Agreement
    Agreement

    SETILE.MENT AGREEMENT AND RELEASE BETWEEN 2 THE BAY AREA AIR QUALITY MANAGEMENT DISTRICT AND 3 CHEMTRADE WEST US LLC 4 1. The BAY AREA AIR QUALITY MANAGEMENT DISTRICT ("DISTRICT") and 5 6 ...

    Read More
    (614 Kb PDF, 4 pgs)

    SETILE.MENT AGREEMENT AND RELEASE BETWEEN 2 THE BAY AREA AIR QUALITY MANAGEMENT DISTRICT AND 3 CHEMTRADE WEST US LLC 4 1. The BAY AREA AIR QUALITY MANAGEMENT DISTRICT ("DISTRICT") and 5 6 ...

  • Meeting Slides
    Meeting Slides

    Mar 9, 2023 ... WOCAP Steering Committee November 2, 2022 West Oakland Community Action ...

    Read More
    (7 Mb PDF, 31 pgs)

    Mar 9, 2023 ... WOCAP Steering Committee November 2, 2022 West Oakland Community Action ...

  • CAC 2024-2025 Work Plan
    CAC 2024-2025 Work Plan

    Calendar of Agenda Items (2024-2025 Work Plan) CAC Member Lead-Subject to Work Plan Agenda Items Potential Recommendations (or Information Only) Description of Community Benefit Change Develop ...

    Read More
    (51 Kb PDF, 2 pgs)

    Calendar of Agenda Items (2024-2025 Work Plan) CAC Member Lead-Subject to Work Plan Agenda Items Potential Recommendations (or Information Only) Description of Community Benefit Change Develop ...

  • 709283 Permit Evaluation
    709283 Permit Evaluation

    Mar 20, 2025 ... Montezuma Wetlands, LLC Facility #: 203615 Application #: 709283 DRAFT ENGINEERING EVALUATION Montezuma Wetlands, LLC 1285 Collinsville Road, Suisun City, CA 94585 Facility #: 203615 ...

    Read More
    (1 Mb PDF, 37 pgs)

    Mar 20, 2025 ... Montezuma Wetlands, LLC Facility #: 203615 Application #: 709283 DRAFT ENGINEERING EVALUATION Montezuma Wetlands, LLC 1285 Collinsville Road, Suisun City, CA 94585 Facility #: 203615 ...

  • Meeting Notes
    Meeting Notes

    Mar 4, 2024 ... B a y v i e w H u n t e r s Po i n t / S o u t h e a s t S a n F ra n c i s c o A B 6 1 7 C o m m u n i t y S t e e r i n g C o m m i t t e e Me e t i n g Me e t i n g S u m m a r y Tuesday, February ...

    Read More
    (134 Kb PDF, 4 pgs)

    Mar 4, 2024 ... B a y v i e w H u n t e r s Po i n t / S o u t h e a s t S a n F ra n c i s c o A B 6 1 7 C o m m u n i t y S t e e r i n g C o m m i t t e e Me e t i n g Me e t i n g S u m m a r y Tuesday, February ...

  • HHHHHH Instructions
    HHHHHH Instructions

    May 2, 2008 ... What Is The Compliance Date? You can also contact your Regional EPA air toxics United States April 2008 office at the ...

    Read More
    (69 Kb PDF, 2 pgs)

    May 2, 2008 ... What Is The Compliance Date? You can also contact your Regional EPA air toxics United States April 2008 office at the ...

Spare the Air Status

Huling Isinapanahon: 11/8/2016